Margaret Elizabeth HARGATHER

Margaret Elizabeth HARGATHER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Margaret Elizabeth HARGATHER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Name Margaret HARGARTHER [21]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 18. Mai 1882 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Tod Dezember 1969 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1952 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1934 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1921 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1960 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1959 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1948 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1930 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1935 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Wohnen 1. April 1940 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]
Heirat 28. April 1908 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. April 1908
Rochester, Monroe, New York, USA
Georg Theodore SCHICKER

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 6B; Enumeration District: 0059; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
21 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
28 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 6B; Enumeration District: 0059; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 6B; Enumeration District: 0059; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
43 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
44 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
45 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
46 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
47 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
48 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
49 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
50 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person