Georg Theodore SCHICKER

Georg Theodore SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Georg Theodore SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
Name Theodor SCHICKER

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 6. Februar 1881 Bamberg, Bayern, Germany nach diesem Ort suchen [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]
Bestattung 11. Dezember 1963 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Tod 8. Dezember 1963 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43] [44] [45]
Wohnen 1963 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]
Wohnen 1952 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Wohnen 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [52]
Wohnen 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [53]
Wohnen 1934 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [54]
Wohnen 1921 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [55]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [56]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [57]
Wohnen 1942 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [58]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [59]
Wohnen 1960 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [60]
Wohnen 1959 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [61]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [62]
Wohnen 1948 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [63]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [64]
Wohnen 1930 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [65]
Wohnen 1935 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [66]
Wohnen 1. April 1940 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [67]
Departure Bremerhaven, Bremen, Germany nach diesem Ort suchen [68]
Arrival 3. April 1882 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [69] [70]
Heirat 28. April 1908 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. April 1908
Rochester, Monroe, New York, USA
Margaret Elizabeth HARGATHER

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818807; Draft Board: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-07-4279; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
26 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
27 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 1900 US Census, NY, Monroe Co, Rochester, Ward 8, at 15 Mark St
29 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818807; Draft Board: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-07-4279; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
38 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
42 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-07-4279; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
44 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
45 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
46 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
47 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
48 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
49 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
50 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818807; Draft Board: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
51 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
52 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
53 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
54 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
55 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
56 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
57 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
58 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
59 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
60 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
61 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
62 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
63 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
64 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
65 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
66 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
67 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
68 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
69 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
70 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person