Georg Theodore SCHICKER
♂ Georg Theodore SCHICKER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Georg Theodore SCHICKER | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] | ||
Name | Theodor SCHICKER |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 6. Februar 1881 | Bamberg, Bayern, Germany nach diesem Ort suchen | [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] |
Bestattung | 11. Dezember 1963 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [42] |
Tod | 8. Dezember 1963 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [43] [44] [45] |
Wohnen | 1963 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [46] |
Wohnen | 1892 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [47] |
Wohnen | 1. Juni 1915 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [48] |
Wohnen | 1. Juni 1925 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [49] |
Wohnen | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [50] | |
Wohnen | 1952 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [51] |
Wohnen | 1918 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [52] |
Wohnen | 1917 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [53] |
Wohnen | 1934 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [54] |
Wohnen | 1921 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [55] |
Wohnen | 1951 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [56] |
Wohnen | 1938 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [57] |
Wohnen | 1942 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [58] |
Wohnen | 1910 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [59] |
Wohnen | 1960 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [60] |
Wohnen | 1959 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [61] |
Wohnen | 1920 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [62] |
Wohnen | 1948 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [63] |
Wohnen | 1900 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [64] |
Wohnen | 1930 | Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [65] |
Wohnen | 1935 | Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [66] |
Wohnen | 1. April 1940 | Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen | [67] |
Departure | Bremerhaven, Bremen, Germany nach diesem Ort suchen | [68] | |
Arrival | 3. April 1882 | New York, New York, USA nach diesem Ort suchen | [69] [70] |
Heirat | 28. April 1908 | Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
28. April 1908 Rochester, Monroe, New York, USA |
Margaret Elizabeth HARGATHER |
|
Notizen zu dieser Person
Quellenangaben
1 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
2 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
3 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818807; Draft Board: 5 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
4 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
5 | New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
6 | U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-07-4279; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
7 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
8 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
9 | New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
10 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
11 | U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
12 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
13 | New York, State Census, 1892 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
14 | U.S. City Directories, 1941 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
15 | U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
16 | U.S. City Directories, 1941 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
17 | U.S. City Directories, 1941 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
18 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
19 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
20 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
21 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
22 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
23 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
24 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
25 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; |
26 | New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018; |
27 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
28 | 1900 US Census, NY, Monroe Co, Rochester, Ward 8, at 15 Mark St |
29 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
30 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818807; Draft Board: 5 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
31 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
32 | New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
33 | U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-07-4279; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
34 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
35 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
36 | New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
37 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
38 | U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
39 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
40 | New York, State Census, 1892 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
41 | New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018; |
42 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
43 | U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-07-4279; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
44 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
45 | New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018; |
46 | New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018; |
47 | New York, State Census, 1892 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
48 | New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 16 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
49 | New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 12 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
50 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818807; Draft Board: 5 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
51 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
52 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
53 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
54 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
55 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
56 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
57 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
58 | U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
59 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 11A; Enumeration District: 0085; FHL microfilm: 1375004 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
60 | U.S. City Directories, 1941 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
61 | U.S. City Directories, 1941 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
62 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15A; Enumeration District: 88; Image: 680 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
63 | U.S. City Directories, 1941 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
64 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
65 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
66 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
67 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 13A; Enumeration District: 28-45 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
68 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
69 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1882; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 448; Line: 9; List Number: 391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
70 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 26B; Enumeration District: 0222; Image: 274.0; FHL microfilm: 2341182 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
Datenbank
Titel | Family Grimes Stammbaum |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-08-30 07:34:24.0 |
Einsender | Michael Grimes |
oneofmanyangels@gmail.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |