William Herman GUETERSLOH

William Herman GUETERSLOH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name William Herman GUETERSLOH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 6. Oktober 1869 New York nach diesem Ort suchen [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Tod 30. Oktober 1961 New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1870 New York Ward 10 District 8, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1910 Leonia, Bergen, New Jersey, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1920 Leonia, Bergen, New Jersey, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1. Juni 1925 Pittsford, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1928 Pittsford, NY nach diesem Ort suchen
Wohnen 1930 Rochester, New York, USA nach diesem Ort suchen [31] [32]
Wohnen 1933 Rochester, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1935 Pittsford, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1940 Pittsford, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1944 Pittsford, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1946 Pittsford, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen Pittsford, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Arrival 15. November 1928 New York, New York nach diesem Ort suchen [39]
Death Notice 1. November 1961 Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [40]
Departure Kingston, Jamaica nach diesem Ort suchen [41]
Heirat 10. Oktober 1898 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
10. Oktober 1898
Manhattan, New York, USA
Annie M NEELS

Quellenangaben

1 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: New York Ward 10 District 8, New York, New York; Roll: M593_985; Page: 324A; Family History Library Film: 552484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4384; Line: 2; Page Number: 141
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0249; FHL microfilm: 2341183
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Leonia, Bergen, New Jersey; Roll: T624_869; Page: 18B; Enumeration District: 0029; FHL microfilm: 1374882
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 4A; Enumeration District: 28-79
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 02; Assembly District: 01; City: Pittsford; County: Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Leonia, Bergen, New Jersey; Roll: T625_1018; Page: 4B; Enumeration District: 57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New Hampshire, Marriage and Divorce Records, 1659-1947, New England Historical Genealogical Society; New Hampshire Bureau of Vital Records, Concord, New Hampshire
Autor: Ancestry,com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: New York Ward 10 District 8, New York, New York; Roll: M593_985; Page: 324A; Family History Library Film: 552484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4384; Line: 2; Page Number: 141
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0249; FHL microfilm: 2341183
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Leonia, Bergen, New Jersey; Roll: T624_869; Page: 18B; Enumeration District: 0029; FHL microfilm: 1374882
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 4A; Enumeration District: 28-79
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 02; Assembly District: 01; City: Pittsford; County: Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Leonia, Bergen, New Jersey; Roll: T625_1018; Page: 4B; Enumeration District: 57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: New York Ward 10 District 8, New York, New York; Roll: M593_985; Page: 324A; Family History Library Film: 552484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Leonia, Bergen, New Jersey; Roll: T624_869; Page: 18B; Enumeration District: 0029; FHL microfilm: 1374882
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Leonia, Bergen, New Jersey; Roll: T625_1018; Page: 4B; Enumeration District: 57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 02; Assembly District: 01; City: Pittsford; County: Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0249; FHL microfilm: 2341183
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 4A; Enumeration District: 28-79
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Pittsford, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 4A; Enumeration District: 28-79
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4384; Line: 2; Page Number: 141
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1 Nov 1961 - Page Page 15, 1 Nov 1961
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
41 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4384; Line: 2; Page Number: 141
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Adams Family Ancestry
Beschreibung
Hochgeladen 2023-12-13 17:28:32.0
Einsender user's avatar Ellen De Carlo
E-Mail ellendecarlo1@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person