John HEISS

John HEISS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name John HEISS [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 20. März 1887 Berlin, Germany nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
Tod 19. Dezember 1974 New York, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38]
Wohnen 1892 Brooklyn, Kings, New York nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1900 Brooklyn Ward 28, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1910 Brooklyn Ward 27, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1. Juni 1915 New York, Kings, New York, United States nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1. Juni 1925 New York, Queens, New York, United States nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1930 Queens, Queens, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1935 Athens, Greene, New York nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1940 Athens, Greene, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1950 Athens, Greene, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1969 New York City nach diesem Ort suchen
Wohnen Athens, Greene, New York nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Arrival 24. Februar 1888 Port of New York, New York, United States nach diesem Ort suchen [50] [51] [52] [53] [54]
Heiss Corp 18. Mai 1922 New York, New York nach diesem Ort suchen [55]
Heiss 7. November 1923 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [56]
Heiss (cont) 7. November 1923 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [57]
Heiss 14. Juni 1924 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [58]
Spiritualist 14. Juni 1924 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [59]
Dr John Heiss & Dr Emmy Heiss 20. Dezember 1924 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [60]
Heiss 20. Dezember 1924 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [61]
John Heiss and Houdini 2. November 1926 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [62]
Heiss 28. September 1930 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [63]
John Heiss 28. September 1930 Brooklyn, Kings, New York nach diesem Ort suchen [64]
John Heiss 28. September 1930 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [65]
John Heiss - President of the General Assembly of Spiritualists 28. September 1930 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [66]
Dr John Heiss 21. Mai 1950 Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [67]
Rev John Heiss 19. Juni 1953 Elmira, Chemung, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [68]
Rev John Heiss 31. Mai 1958 Elmira, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [69]
John Heiss 7. Mai 1960 Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [70]
Rev John Heiss 12. Mai 1960 Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [71]
Death Notice 24. Dezember 1974 New York, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [72]
Departure Bremen, Germany nach diesem Ort suchen [73]
Heirat 16. November 1949 Stamford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [74]
Heirat 23. August 1963 Stamford, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [75] [76]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
16. November 1949
Stamford, Connecticut, USA
Cora STONE
Heirat Ehepartner Kinder
23. August 1963
Stamford, Fairfield, Connecticut, USA
Cynthia HOLLINGSWORTH
Heirat Ehepartner Kinder

Ethel HEISS
Heirat Ehepartner Kinder

Emma A NELSON

Quellenangaben

1 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 17 Jun 1928 - Page Page 9, 17 Jun 1928
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
2 New York Port, Ship Images, 1851-1891
3 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Berlin, Germany, Births, 1874-1899, Landesarchiv Berlin; Berlin, Deutschland; Laufendenummer: 735
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Athens, Greene, New York; Roll: m-t0627-02540; Page: 6B; Enumeration District: 20-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 61; Assembly District: 06; City: New York; County: Queens; Page: 27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 17; Assembly District: 05; City: New York; County: Kings; Page: 05
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Brooklyn Ward 28, Kings, New York; Page: 1; Enumeration District: 0533
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 27, Kings, New York; Roll: T624_979; Page: 10A; Enumeration District: 0820; FHL microfilm: 1374992
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Queens, Queens, New York; Roll: 1597; Page: 1A; Enumeration District: 0333; FHL microfilm: 2341332
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1888; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 516; Line: 7; List Number: 231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 099-01-3713; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Kings; Roll: 1754599; Draft Board: 71
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Connecticut, Marriage Index, 1959-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Daily News; Publication Date: 24/ Dec/ 1974; Publication Place: New York, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/395808341/?article=b61813a7-eebb-4e21-a19b-8f7e657dd500&focus=0.63265157,0.2160192,0.80286205,0.2490
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Daily News; Publication Date: 24 Dec 1974; Publication Place: New York, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/464406045/?article=ea869a26-0906-4fc2-984c-a980c870f996&focus=0.6036837,0.22652578,0.776811,0.2584505&
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Athens, Gree
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 New York Port, Ship Images, 1851-1891
22 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Berlin, Germany, Births, 1874-1899, Landesarchiv Berlin; Berlin, Deutschland; Laufendenummer: 735
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Athens, Greene, New York; Roll: m-t0627-02540; Page: 6B; Enumeration District: 20-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 61; Assembly District: 06; City: New York; County: Queens; Page: 27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 17; Assembly District: 05; City: New York; County: Kings; Page: 05
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Brooklyn Ward 28, Kings, New York; Page: 1; Enumeration District: 0533
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 27, Kings, New York; Roll: T624_979; Page: 10A; Enumeration District: 0820; FHL microfilm: 1374992
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Queens, Queens, New York; Roll: 1597; Page: 1A; Enumeration District: 0333; FHL microfilm: 2341332
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1888; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 516; Line: 7; List Number: 231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 099-01-3713; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Kings; Roll: 1754599; Draft Board: 71
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 Connecticut, Marriage Index, 1959-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Athens, Gree
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 099-01-3713; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Daily News; Publication Date: 24/ Dec/ 1974; Publication Place: New York, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/395808341/?article=b61813a7-eebb-4e21-a19b-8f7e657dd500&focus=0.63265157,0.2160192,0.80286205,0.2490
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Daily News; Publication Date: 24 Dec 1974; Publication Place: New York, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/464406045/?article=ea869a26-0906-4fc2-984c-a980c870f996&focus=0.6036837,0.22652578,0.776811,0.2584505&
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Brooklyn Ward 28, Kings, New York; Page: 1; Enumeration District: 0533
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 27, Kings, New York; Roll: T624_979; Page: 10A; Enumeration District: 0820; FHL microfilm: 1374992
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 17; Assembly District: 05; City: New York; County: Kings; Page: 05
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 61; Assembly District: 06; City: New York; County: Queens; Page: 27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Queens, Queens, New York; Roll: 1597; Page: 1A; Enumeration District: 0333; FHL microfilm: 2341332
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Athens, Greene, New York; Roll: m-t0627-02540; Page: 6B; Enumeration District: 20-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Athens, Greene, New York; Roll: m-t0627-02540; Page: 6B; Enumeration District: 20-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Athens, Gree
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Athens, Gree
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 Connecticut, Marriage Index, 1959-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
50 New York Port, Ship Images, 1851-1891
51 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Brooklyn Ward 28, Kings, New York; Page: 1; Enumeration District: 0533
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
52 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Brooklyn Ward 27, Kings, New York; Roll: T624_979; Page: 10A; Enumeration District: 0820; FHL microfilm: 1374992
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
53 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Queens, Queens, New York; Roll: 1597; Page: 1A; Enumeration District: 0333; FHL microfilm: 2341332
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
54 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1888; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 516; Line: 7; List Number: 231
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
55 Newspapers.com - Daily News - 18 May 1922 - Page 23, 18 May 1922
Angaben zur Veröffentlichung: Daily News
56 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 7 Nov 1923 - Page 1, 7 Nov 1923
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
57 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 7 Nov 1923 - Page 3, 7 Nov 1923
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
58 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 14 Jun 1924 - Page 24, 14 Jun 1924
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
59 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 14 Jun 1924 - Page 24, 14 Jun 1924
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
60 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 20 Dec 1924 - Page 29, Dr John Heiss & Dr Emmy Heiss 20 Dec 1924
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
61 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 20 Dec 1924 - Page 29, 20 Dec 1924
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
62 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 2 Nov 1926 - Page 2, John Heiss & Houdini 2 Nov 1926
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
63 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 28 Sep 1930 - Page 77, 28 Sep 1930
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
64 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 28 Sep 1930 - Page Page 77, John Heiss 28 Sep 1930
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
65 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 28 Sep 1930 - Page 77, John Heiss 28 Sep 1930
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
66 Newspapers.com - The Brooklyn Daily Eagle - 28 Sep 1930 - Page 77, John Heiss - President of the General Assembly of Spiritualists of the State of New York 28 Sep 1930
Angaben zur Veröffentlichung: The Brooklyn Daily Eagle
67 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 21 May 1950 - Page Page 23, 21 May 1950
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
68 Newspapers.com - Star-Gazette - 19 Jun 1953 - Page 11, 19 Jun 1953
Angaben zur Veröffentlichung: Star-Gazette
69 Newspapers.com - Elmira Advertiser - 31 May 1958 - Page 3, 31 May 1958
Angaben zur Veröffentlichung: Elmira Advertiser
70 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 7 May 1960 - Page Page 3, 7 May 1960
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
71 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 12 May 1960 - Page Page 44, 12 May 1960
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
72 Newspapers.com - Daily News - 24 Dec 1974 - Page 57, 24 Dec 1974
Angaben zur Veröffentlichung: Daily News
73 New York Port, Ship Images, 1851-1891
74 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
75 Connecticut, Marriage Index, 1959-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
76 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Adams Family Ancestry
Beschreibung
Hochgeladen 2023-12-13 17:28:32.0
Einsender user's avatar Ellen De Carlo
E-Mail ellendecarlo1@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person