Johann Gerhard Heinrich RAUF

Johann Gerhard Heinrich RAUF

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Johann Gerhard Heinrich RAUF [17]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 2. Oktober 1860 Bersenbrück, Osnabrück, Lower Saxony, Germany nach diesem Ort suchen [18]
Bestattung 1938 Mother Of God Cemetery, Kenton Vale, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [19]
Tod 2. März 1938 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1925 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1938 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Arrival 1879 [27] [28] [29]
Heirat 5. Juni 1888 Hamilton County, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [30] [31] [32]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
5. Juni 1888
Hamilton County, Ohio, USA
Maria Louise KREKE

Quellenangaben

1 U.S., Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925; Roll #: 2719; Volume #: Roll 2719 - Certificates: 300-899, 06 Mar 1925-06 Mar 1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911, Kentucky Department of Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky; Kentucky Birth, Marriage and Death Records - Microfilm (1852-1910)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 Ohio, U.S., Births and Christenings Index, 1774-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 1B; Enumeration District: 99
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 12A; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340496
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 1B; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 31 Aug 1947; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100585990/?article=d696ba47-21bc-42d5-ab47-d9262d09604c&focus=0.3785985,0.8838705,0.49960107,0.9185825&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 1B; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 1B; Enumeration District: 99
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925; Roll #: 2719; Volume #: Roll 2719 - Certificates: 300-899, 06 Mar 1925-06 Mar 1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 12A; Enumeration District: 0011; FHL microfilm: 2340496
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 1B; Enumeration District: 99
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 1B; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 3, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 9; Enumeration District: 0096; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person