Mary E HUELEFELD

Mary E HUELEFELD

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Mary E HUELEFELD [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt Mai 1889 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Bestattung 1949 Mother Of God Cemetery, Kenton Vale, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [28]
Tod 24. September 1949 Eastern State Hospital for Insane, Lexington, Fayette, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29] [30] [31] [32]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1908 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1920 Eastern State Hospital for Insane, Lexington, Fayette, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1930 Eastern State Hospital for Insane, Lexington, Fayette, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1935 Eastern State Hospital for Insane, Lexington, Fayette, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1940 Eastern State Hospital for Insane, Lexington, Fayette, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1949 Kenton County, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Lifesketch nach 1920 Eastern State Hospital for Insane, Lexington, Fayette, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Roll: m-t0627-01302; Page: 10A; Enumeration District: 34-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lexington , Fayette, Kentucky; Roll: T625_568; Page: 7B; Enumeration District: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Page: 5A; Enumeration District: 0006; FHL microfilm: 2340478
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Roll: m-t0627-01302; Page: 10A; Enumeration District: 34-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lexington , Fayette, Kentucky; Roll: T625_568; Page: 7B; Enumeration District: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Page: 5A; Enumeration District: 0006; FHL microfilm: 2340478
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Roll: m-t0627-01302; Page: 10A; Enumeration District: 34-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lexington , Fayette, Kentucky; Roll: T625_568; Page: 7B; Enumeration District: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Page: 5A; Enumeration District: 0006; FHL microfilm: 2340478
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find a Grave® Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lexington , Fayette, Kentucky; Roll: T625_568; Page: 7B; Enumeration District: 53
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Page: 5A; Enumeration District: 0006; FHL microfilm: 2340478
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Roll: m-t0627-01302; Page: 10A; Enumeration District: 34-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lexington, Fayette, Kentucky; Roll: m-t0627-01302; Page: 10A; Enumeration District: 34-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person