Charles Joseph HAIS

Charles Joseph HAIS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Charles Joseph HAIS [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 17. Juli 1882 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24] [25]
Bestattung 1954 Saint John Cemetery, Fort Mitchell, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Tod 1954 USA nach diesem Ort suchen [27] [28]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1931 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1935 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1940 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1942 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen etwa 1948 [37]
Lifesketch
Heirat 11. Oktober 1911 Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
11. Oktober 1911
Kenton, Kentucky, USA
Henrietta KLAUSING
Heirat Ehepartner Kinder

Ida KLAUSING

Quellenangaben

1 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 093
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 2A; Enumeration District: 59-24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 2B; Enumeration District: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 9A; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 12; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 4 Jul 1948; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100409253/?article=675b091a-7b30-42ca-a74d-fd9f42019666&focus=0.389883,0.30595762,0.5064167,0.3323096&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 23 May 1918; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/34191763/?article=5b16582e-6dc8-4154-a08a-2e619eea4d2a&focus=0.005026383,0.16172415,0.1334375,0.19967274&xid=335
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 093
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 4 Jul 1948; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100409253/?article=675b091a-7b30-42ca-a74d-fd9f42019666&focus=0.389883,0.30595762,0.5064167,0.3323096&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 23 May 1918; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/34191763/?article=5b16582e-6dc8-4154-a08a-2e619eea4d2a&focus=0.005026383,0.16172415,0.1334375,0.19967274&xid=335
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 093
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Ohio, U.S., Death Records, 1908-1932, 1938-2018, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 12; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 2B; Enumeration District: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 9A; Enumeration District: 0018; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 2A; Enumeration District: 59-24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 2A; Enumeration District: 59-24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 093
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person