Raymond Bernard PRACHT

Raymond Bernard PRACHT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Raymond Bernard PRACHT [18] [19] [20] [21]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 4. September 1893 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24]
Bestattung 1949 Mother Of God Cemetery, Kenton Vale, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25]
Tod 30. Dezember 1949 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1935 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1940 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1942 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 U.S., World War II Draft Cards Young Men, 1940-1947, National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Kentucky, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box: 511
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 21A; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 3A; Enumeration District: 127
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 7B; Enumeration District: 0014; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 5, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 2; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 2A; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 31 Dec 1949; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103649889/?article=edfc6614-a4fd-4107-8b5c-59cd3689a583&focus=0.8452241,0.81780386,0.97337645,0.8915024&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 31 Dec 1949; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103649889/?article=edfc6614-a4fd-4107-8b5c-59cd3689a583&focus=0.8452241,0.81780386,0.97337645,0.8915024&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 31 Dec 1949; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103649889/?article=edfc6614-a4fd-4107-8b5c-59cd3689a583&focus=0.8452241,0.81780386,0.97337645,0.8915024&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 31 Dec 1949; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103649889/?article=edfc6614-a4fd-4107-8b5c-59cd3689a583&focus=0.8452241,0.81780386,0.97337645,0.8915024&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 5, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 2; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 2A; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 3A; Enumeration District: 127
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 7B; Enumeration District: 0014; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 21A; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 21A; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Kentucky; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person