William Joseph ACREE

William Joseph ACREE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name William Joseph ACREE [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 24. August 1876 Mount Zion, Grant, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
Bestattung 1966 Forest Lawn Memorial Park, Erlanger, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Tod 30. Dezember 1966 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37] [38]
Wohnen 1880 Grant, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1900 Mount Zion, Grant, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1917 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1935 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1940 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1945 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1950 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen vor 1951 Ohio, USA nach diesem Ort suchen [49]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911, Kentucky Department of Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky; Kentucky Birth, Marriage and Death Records - Microfilm (1852-1910)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 1B; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., World War I Civilian Draft Registrations, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 4A; Enumeration District: 0014; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Grant, Kentucky; Roll: 415; Page: 32B; Enumeration District: 083
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Mount Zion, Grant, Kentucky; Roll: 522; Page: 15; Enumeration District: 0060; FHL microfilm: 1240522
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 15B; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 7 Aug 1960; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103686880/?article=abc5a361-d202-4590-aa5d-3bfd7f395287&focus=0.73309034,0.72524285,0.848992,0.9062501&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1950 United States Federal Census, National Archives at Washington, DC; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Year: 1950; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 6247; Page: 10; Enumeration District: 121-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 1B; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 15B; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 7 Aug 1960; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103686880/?article=abc5a361-d202-4590-aa5d-3bfd7f395287&focus=0.73309034,0.72524285,0.848992,0.9062501&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1950 United States Federal Census, National Archives at Washington, DC; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Year: 1950; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 6247; Page: 10; Enumeration District: 121-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911, Kentucky Department of Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky; Kentucky Birth, Marriage and Death Records - Microfilm (1852-1910)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 1B; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 15B; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1950 United States Federal Census, National Archives at Washington, DC; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Year: 1950; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 6247; Page: 10; Enumeration District: 121-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Grant, Kentucky; Roll: 415; Page: 32B; Enumeration District: 083
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Mount Zion, Grant, Kentucky; Roll: 522; Page: 15; Enumeration District: 0060; FHL microfilm: 1240522
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 15B; Enumeration District: 0102; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T625_583; Page: 5A; Enumeration District: 104
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 4A; Enumeration District: 0014; FHL microfilm: 2340497
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 1B; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01323; Page: 1B; Enumeration District: 59-20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 1950 United States Federal Census, National Archives at Washington, DC; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Year: 1950; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 6247; Page: 10; Enumeration District: 121-45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person