Eugene MEYER

Eugene MEYER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Eugene MEYER [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 20. Juni 1862 Durlinsdorf, Haut-Rhin, Alsace, France nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
Bestattung 1911 Saints Peter and Paul Church Cemetery, Gubser, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Tod 18. Oktober 1911 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38] [39]
Wohnen 1866 Schildsgass, Durlinsdorf, 6 M, Haut-Rhin, France nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1880 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1900 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1910 Grants Lick, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Arrival 1872 [44]
Heirat 5. März 1889 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45] [46]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
5. März 1889
Campbell, Kentucky, USA
Elizabeth SPRAUER

Quellenangaben

1 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 409; Volume #: Roll 409 - 14 Jul 1893-31 Aug 1893
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 407; Page: 320D; Enumeration District: 046
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: T624_467; Page: 18A; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 1374480
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 Kentucky, U.S., Wills and Probate Records, 1774-1989, Administrative and Executive Bonds, 1795-1920; Author: Kentucky. County Court (Campbell County); Probate Place: Campbell, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 Indiana, Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Haut Rhin, France, Births, Marriages, and Deaths 1504-1922, Archives Départementales Du Haut-Rhin; Colmar, France; Etat Civil 1793-1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Haut Rhin, France, Census, 1866, Archives départementales du Haut-Rhin; Colmar, France; Recensement 1866
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 409; Volume #: Roll 409 - 14 Jul 1893-31 Aug 1893
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 407; Page: 320D; Enumeration District: 046
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Indiana, Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 Haut Rhin, France, Births, Marriages, and Deaths 1504-1922, Archives Départementales Du Haut-Rhin; Colmar, France; Etat Civil 1793-1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 409; Volume #: Roll 409 - 14 Jul 1893-31 Aug 1893
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 407; Page: 320D; Enumeration District: 046
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Haut Rhin, France, Births, Marriages, and Deaths 1504-1922, Archives Départementales Du Haut-Rhin; Colmar, France; Etat Civil 1793-1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Haut Rhin, France, Census, 1866, Archives départementales du Haut-Rhin; Colmar, France; Recensement 1866
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 407; Page: 320D; Enumeration District: 046
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: T624_467; Page: 18A; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 1374480
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grants Lick, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 15; Enumeration District: 0039; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
46 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person