Bessie SIMPSON

Bessie SIMPSON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Bessie SIMPSON [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt April 1898 Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Tod USA nach diesem Ort suchen [28] [29]
Wohnen 1900 Buckeye, Garrard, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Buckeye, Garrard, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1920 Buckeye, Garrard, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1930 Kirksville, Madison, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1935 Madison nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1940 Mag Dist 3, Garrard, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Heirat 1. Mai 1917 Madison, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36] [37]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1. Mai 1917
Madison, Kentucky, USA
Ballard Estel TUSSEY

Quellenangaben

1 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Garrard, Kentucky; Roll: m-t0627-01308; Page: 2B; Enumeration District: 40-7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T625_570; Page: 1B; Enumeration District: 62
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kirksville, Madison, Kentucky; Page: 8A; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 2340504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: 522; Page: 10; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 1240522
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 14A; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 Indiana, Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Garrard, Kentucky; Roll: m-t0627-01308; Page: 2B; Enumeration District: 40-7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T625_570; Page: 1B; Enumeration District: 62
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kirksville, Madison, Kentucky; Page: 8A; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 2340504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: 522; Page: 10; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 1240522
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 14A; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Indiana, Marriages, 1810-2001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Garrard, Kentucky; Roll: m-t0627-01308; Page: 2B; Enumeration District: 40-7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T625_570; Page: 1B; Enumeration District: 62
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kirksville, Madison, Kentucky; Page: 8A; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 2340504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: 522; Page: 10; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 1240522
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 14A; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: 522; Page: 10; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 1240522
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 14A; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Buckeye, Garrard, Kentucky; Roll: T625_570; Page: 1B; Enumeration District: 62
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kirksville, Madison, Kentucky; Page: 8A; Enumeration District: 0021; FHL microfilm: 2340504
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Garrard, Kentucky; Roll: m-t0627-01308; Page: 2B; Enumeration District: 40-7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Garrard, Kentucky; Roll: m-t0627-01308; Page: 2B; Enumeration District: 40-7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person