Ida J GEIMAN

Ida J GEIMAN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ida J GEIMAN [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 23. August 1879 Wilder, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
Bestattung 1943 Saint Stephen Cemetery, Fort Thomas, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34] [35]
Tod 25. Juli 1943 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38] [39]
Wohnen 1880 Johns Hill, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1900 Johns Hill, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1920 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1930 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1935 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1. April 1940 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1943 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [46]
Heirat 31. Juli 1895 Hamilton County, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [47] [48] [49]
Heirat 22. Juni 1914 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [50]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
31. Juli 1895
Hamilton County, Ohio, USA
Reinhart JAEGER

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Campbell, Kentucky; Roll: T627_1290; Page: 15A; Enumeration District: 19-92
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Johns Hill, Campbell, Kentucky; Roll: 408; Family History Film: 1254408; Page: 378B; Enumeration District: 050; Image: 0038
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Johnshill, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 6A; Enumeration District: 0035; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, The Kentucky Post; Publication Date: 27 Jul 1943; Publication Place: Covington, Kentucky, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/760819247/?article=24e2982d-f506-4b64-a55e-f2a4606f85d1&focus=0.37633893,0.22063066,0.49641308,0.24927263&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Web: Kentucky, Find A Grave Index, 1776-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Campbell, Kentucky; Roll: T627_1290; Page: 15A; Enumeration District: 19-92
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Johns Hill, Campbell, Kentucky; Roll: 408; Family History Film: 1254408; Page: 378B; Enumeration District: 050; Image: 0038
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Johnshill, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 6A; Enumeration District: 0035; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Web: Kentucky, Find A Grave Index, 1776-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Campbell, Kentucky; Roll: T627_1290; Page: 15A; Enumeration District: 19-92
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Johns Hill, Campbell, Kentucky; Roll: 408; Family History Film: 1254408; Page: 378B; Enumeration District: 050; Image: 0038
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Johnshill, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 6A; Enumeration District: 0035; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Web: Kentucky, Find A Grave Index, 1776-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 Web: Kentucky, Find A Grave Index, 1776-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 Web: Kentucky, Find A Grave Index, 1776-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Johns Hill, Campbell, Kentucky; Roll: 408; Family History Film: 1254408; Page: 378B; Enumeration District: 050; Image: 0038
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Johnshill, Campbell, Kentucky; Roll: 513; Page: 6A; Enumeration District: 0035; FHL microfilm: 1240513
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Campbell, Kentucky; Roll: T627_1290; Page: 15A; Enumeration District: 19-92
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Campbell, Kentucky; Roll: T627_1290; Page: 15A; Enumeration District: 19-92
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
47 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, The Kentucky Post; Publication Date: 27 Jul 1943; Publication Place: Covington, Kentucky, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/760819247/?article=24e2982d-f506-4b64-a55e-f2a4606f85d1&focus=0.37633893,0.22063066,0.49641308,0.24927263&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
49 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
50 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person