Ealum PIGMON

Ealum PIGMON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ealum PIGMON [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 3. Juni 1881 Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Tod 28. Oktober 1940 [21]
Wohnen 1900 Carr, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1910 Upper Carr, Knott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1918 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Bet. 1917–1918") Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1920 Colson, Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1930 Rockhouse, Letcher, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Race

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Mary E FRANKLIN

Quellenangaben

1 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Colson, Letcher, Kentucky; Roll: T625_587; Page: 3A; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rockhouse, Letcher, Kentucky; Page: 7A; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2340500
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Carr, Knott, Kentucky; Roll: 536; Page: 8; Enumeration District: 0044; FHL microfilm: 1240536
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Upper Carr, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 8B; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 One World Tree
8 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Colson, Letcher, Kentucky; Roll: T625_587; Page: 3A; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rockhouse, Letcher, Kentucky; Page: 7A; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2340500
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Carr, Knott, Kentucky; Roll: 536; Page: 8; Enumeration District: 0044; FHL microfilm: 1240536
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Upper Carr, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 8B; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 One World Tree
15 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Colson, Letcher, Kentucky; Roll: T625_587; Page: 3A; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rockhouse, Letcher, Kentucky; Page: 7A; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2340500
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Carr, Knott, Kentucky; Roll: 536; Page: 8; Enumeration District: 0044; FHL microfilm: 1240536
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Upper Carr, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 8B; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 One World Tree
21 One World Tree
22 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Carr, Knott, Kentucky; Roll: 536; Page: 8; Enumeration District: 0044; FHL microfilm: 1240536
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Upper Carr, Knott, Kentucky; Roll: T624_482; Page: 8B; Enumeration District: 0083; FHL microfilm: 1374495
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Letcher County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Colson, Letcher, Kentucky; Roll: T625_587; Page: 3A; Enumeration District: 60
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rockhouse, Letcher, Kentucky; Page: 7A; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2340500
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person