John Albert WISCHER

John Albert WISCHER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name John Albert WISCHER [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 14. November 1888 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Bestattung 1918 Mother Of God Cemetery, Kenton Vale, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Tod 23. Oktober 1918 Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27] [28] [29] [30]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 5, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 24 Jan 1955; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104043658/?article=c5d5fe48-3ad0-4bda-86b5-278d351e5ed0&focus=0.7328042,0.6351357,0.84716356,0.77215815&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 5, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 24 Jan 1955; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/104043658/?article=c5d5fe48-3ad0-4bda-86b5-278d351e5ed0&focus=0.7328042,0.6351357,0.84716356,0.77215815&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 5, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 5, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Kenton
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person