Catherine HUNT

Catherine HUNT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Catherine HUNT [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Juli 1869 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
Bestattung 1943 Saint Mary's Cemetery, Fort Mitchell, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Tod 21. Mai 1943 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34] [35] [36] [37] [38]
Wohnen 1870 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1880 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1920 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1930 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1931 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1935 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1940 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [47]
Lifesketch

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911, Kentucky Department of Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky; Kentucky Birth, Marriage and Death Records - Microfilm (1852-1910)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 4A; Enumeration District: 59-47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 10B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 11A; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 2340496
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1870 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 7; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 11B; Enumeration District: 0120; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1955; Roll: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Post; Publication Date: 22 May 1943; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/762716017/?article=88f6af14-967b-478c-ae2f-49ab6e5a6335&focus=0.2708109,0.8096924,0.38509429,0.82925504&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 4A; Enumeration District: 59-47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 10B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 7; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1955; Roll: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Post; Publication Date: 22 May 1943; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/762716017/?article=88f6af14-967b-478c-ae2f-49ab6e5a6335&focus=0.2708109,0.8096924,0.38509429,0.82925504&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 4A; Enumeration District: 59-47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 10B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 7; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Post; Publication Date: 22 May 1943; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/762716017/?article=88f6af14-967b-478c-ae2f-49ab6e5a6335&focus=0.2708109,0.8096924,0.38509429,0.82925504&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1870 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 7; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 11B; Enumeration District: 0120; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Covington Ward 6, Kenton, Kentucky; Roll: T625_584; Page: 10B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Page: 11A; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 2340496
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 4A; Enumeration District: 59-47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: m-t0627-01324; Page: 4A; Enumeration District: 59-47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person