Alfons Erhard FONTHEIM

Alfons Erhard FONTHEIM

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Alfons Erhard FONTHEIM [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1886 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "11 Sept 1886") Berlin, Berlin, Deutschland nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Bestattung 1938 Cortland, Cortland County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [20]
Tod 30. Juni 1938 Orangetown, New York, USA nach diesem Ort suchen [21] [22]
Wohnen 1909 Germany nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1910 Manhattan Ward 19, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1914 Germany nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1924 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Departure 1909 Bremen nach diesem Ort suchen [27]
Arrival 10. Februar 1909 New York, New York nach diesem Ort suchen [28] [29]
Departure 1914 Hamburg nach diesem Ort suchen [30]
Arrival 11. April 1914 New York, New York nach diesem Ort suchen [31] [32] [33]
NaturalizationDeclaration 31. Juli 1919 [34]
NaturalizationPetition New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Heirat 20. September 1930 Greenwich, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [36]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
20. September 1930
Greenwich, Connecticut, USA
Dores HOWARD

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Berlin, Germany, Births, 1874-1899, Landesarchiv Berlin; Berlin, Deutschland; Personenstandsregister Geburtsregister; Laufendenummer: 558
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 19, New York, New York; Roll: T624_1043; Page: 11A; Enumeration District: 1163; FHL microfilm: 1375056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 New York, New York, Voter List, 1924, New York City Municipal Archive; New York, New York, USA; 1924 NYC Voter List
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 2293; Line: 25; Page Number: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
7 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1909; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1198; Line: 3; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
9 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, National Archives and Records Administration; Washington, DC; NAI Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Berlin, Germany, Births, 1874-1899, Landesarchiv Berlin; Berlin, Deutschland; Personenstandsregister Geburtsregister; Laufendenummer: 558
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 19, New York, New York; Roll: T624_1043; Page: 11A; Enumeration District: 1163; FHL microfilm: 1375056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 2293; Line: 25; Page Number: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
16 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1909; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1198; Line: 3; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
18 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, National Archives and Records Administration; Washington, DC; NAI Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1909; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1198; Line: 3; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
24 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 19, New York, New York; Roll: T624_1043; Page: 11A; Enumeration District: 1163; FHL microfilm: 1375056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 2293; Line: 25; Page Number: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
26 New York, New York, Voter List, 1924, New York City Municipal Archive; New York, New York, USA; 1924 NYC Voter List
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1909; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1198; Line: 3; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
28 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 19, New York, New York; Roll: T624_1043; Page: 11A; Enumeration District: 1163; FHL microfilm: 1375056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1909; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1198; Line: 3; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
30 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 2293; Line: 25; Page Number: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
31 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 2293; Line: 25; Page Number: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
32 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, National Archives and Records Administration; Washington, DC; NAI Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, National Archives and Records Administration; Washington, DC; NAI Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Cour
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Weule-Woile-Datenbank 2022
Beschreibung
Hochgeladen 2022-02-13 20:53:23.0
Einsender user's avatar Reinhard Weule
E-Mail reinhard.weule@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person