Patrick Joseph FEERICK

Patrick Joseph FEERICK

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Patrick Joseph FEERICK [2] [3] [4]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1874 Ireland nach diesem Ort suchen [5] [6]
Tod 2. Februar 1937 California nach diesem Ort suchen
Wohnen 1905 Ireland nach diesem Ort suchen [7]
Wohnen 1920 San Francisco Assembly District 28, San Francisco, California nach diesem Ort suchen [8]
Wohnen 1925 San Francisco, California, USA nach diesem Ort suchen [9]
Departure 1905 Queenstown, Ireland nach diesem Ort suchen [10]
Arrival 4. Oktober 1905 New York, New York nach diesem Ort suchen [11] [12]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Catherine M PURCELL

Quellenangaben

1
2 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
3 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: San Francisco Assembly District 28, San Francisco, California
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic
4 U.S. City Directories (Beta)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.Original data - Original sources vary according to directory. The title of the specific directory being viewed is listed at the top of the image viewer page. Check the directory titl
5 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: San Francisco Assembly District 28, San Francisco, California
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic
7 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
8 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: San Francisco Assembly District 28, San Francisco, California
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic
9 U.S. City Directories (Beta)
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.Original data - Original sources vary according to directory. The title of the specific directory being viewed is listed at the top of the image viewer page. Check the directory titl
10 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
11 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
12 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: San Francisco Assembly District 28, San Francisco, California
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic

Datenbank

Titel Weule-Woile-Datenbank 2022
Beschreibung
Hochgeladen 2022-02-13 20:53:23.0
Einsender user's avatar Reinhard Weule
E-Mail reinhard.weule@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person