Francis Andrew EFFINGER

Francis Andrew EFFINGER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Francis Andrew EFFINGER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 8. Juli 1917 Rochester, Monroe County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung Rochester, Monroe County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [24] [25]
Tod 11. Juni 1965 Rochester, Monroe County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29]
Wohnen 1920 Rochester Ward 18, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1925 Rochester Ward 18, Monroe nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 42 Teresa St. nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen Beechwood, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen Monroe, New York nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen Roch, Mon, New York nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen Rochester, New York nach diesem Ort suchen [39]

Quellenangaben

1 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 USA, Einzugsregistrierungskarten junger Männer, 2. Weltkrieg, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 New York, USA, Dienstkarten der Guard von New York, 1906-1918, 1940-1948, New York State Archives; Albany, New York; Collection: New York, New York Guard Service Cards and Enlistment Records, 1906-1918, 1940-1948; Series: B2000; Film Number: 47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 USA, Grabsteinanträge für Veteranen des Militärs, 1925-1970, National Archives at St. Louis, MO; St. Louis, MO, USA; Applications for Headstones, 1/1/1925 - 6/30/1970; NAID: NAID 596118; Record Group Number: 92; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, Democrat and Chronicle; Publication Date: 12 Jun 1965; Publication Place: Rochester, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/136521705/?article=877ddfec-6b1e-487c-bec3-71f9cb46f12a&focus=0.48953372,0.31810147,0.605
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 New York, USA, staatliche Volkszählung, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 18; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 18; County: Monroe; Page: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Bundesstaat New York, Geburtenindex, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 US-amerikanisches Einberufungsregister für den 2. Weltkrieg, 1938–1946, National Archives at College Park; College Park, Maryland, USA; Electronic Army Serial Number Merged File, 1938-1946; NAID: 1263923; Record Group Title: Records of the National Archives and Records Administration, 1789-ca. 2007; Record Group: 64; B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Bundesstaat New York, Sterbeindex, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0133; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 15A; Enumeration District: 215
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02849; Page: 8B; Enumeration District: 65-244
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 USA, Einzugsregistrierungskarten junger Männer, 2. Weltkrieg, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, USA, Dienstkarten der Guard von New York, 1906-1918, 1940-1948, New York State Archives; Albany, New York; Collection: New York, New York Guard Service Cards and Enlistment Records, 1906-1918, 1940-1948; Series: B2000; Film Number: 47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 USA, Grabsteinanträge für Veteranen des Militärs, 1925-1970, National Archives at St. Louis, MO; St. Louis, MO, USA; Applications for Headstones, 1/1/1925 - 6/30/1970; NAID: NAID 596118; Record Group Number: 92; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York, USA, staatliche Volkszählung, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 18; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 18; County: Monroe; Page: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Bundesstaat New York, Geburtenindex, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 US-amerikanisches Einberufungsregister für den 2. Weltkrieg, 1938–1946, National Archives at College Park; College Park, Maryland, USA; Electronic Army Serial Number Merged File, 1938-1946; NAID: 1263923; Record Group Title: Records of the National Archives and Records Administration, 1789-ca. 2007; Record Group: 64; B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Bundesstaat New York, Sterbeindex, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0133; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 15A; Enumeration District: 215
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02849; Page: 8B; Enumeration District: 65-244
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 USA, Grabsteinanträge für Veteranen des Militärs, 1925-1970, National Archives at St. Louis, MO; St. Louis, MO, USA; Applications for Headstones, 1/1/1925 - 6/30/1970; NAID: NAID 596118; Record Group Number: 92; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 USA, Grabsteinanträge für Veteranen des Militärs, 1925-1970, National Archives at St. Louis, MO; St. Louis, MO, USA; Applications for Headstones, 1/1/1925 - 6/30/1970; NAID: NAID 596118; Record Group Number: 92; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, Democrat and Chronicle; Publication Date: 12 Jun 1965; Publication Place: Rochester, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/136521705/?article=877ddfec-6b1e-487c-bec3-71f9cb46f12a&focus=0.48953372,0.31810147,0.605
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 Bundesstaat New York, Sterbeindex, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 15A; Enumeration District: 215
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 New York, USA, staatliche Volkszählung, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 18; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 18; County: Monroe; Page: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0133; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02849; Page: 8B; Enumeration District: 65-244
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02849; Page: 8B; Enumeration District: 65-244
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, Democrat and Chronicle; Publication Date: 12 Jun 1965; Publication Place: Rochester, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/136521705/?article=877ddfec-6b1e-487c-bec3-71f9cb46f12a&focus=0.48953372,0.31810147,0.605
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 Bundesstaat New York, Sterbeindex, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 US-amerikanisches Einberufungsregister für den 2. Weltkrieg, 1938–1946, National Archives at College Park; College Park, Maryland, USA; Electronic Army Serial Number Merged File, 1938-1946; NAID: 1263923; Record Group Title: Records of the National Archives and Records Administration, 1789-ca. 2007; Record Group: 64; B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 USA, Einzugsregistrierungskarten junger Männer, 2. Weltkrieg, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 New York, USA, Dienstkarten der Guard von New York, 1906-1918, 1940-1948, New York State Archives; Albany, New York; Collection: New York, New York Guard Service Cards and Enlistment Records, 1906-1918, 1940-1948; Series: B2000; Film Number: 47
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Häring 2023
Beschreibung
Hochgeladen 2023-03-19 21:23:13.0
Einsender user's avatar André Häring
E-Mail andre.haering@bluewin.ch
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person