Friedrich "Otto" STREIT STEINER

Friedrich "Otto" STREIT STEINER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Friedrich "Otto" STREIT STEINER [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Name Friedrich Otto STREIT STEINER [19]
Name Friedrich Otto STREIT

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 9. Oktober 1881 Bowil, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Bern, Switzerland nach diesem Ort suchen [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
Geburt 9. Oktober 1881 Bowil, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Bern, Berne, Suisse nach diesem Ort suchen [31]
Geburt 9. Oktober 1881 Bowil, Bern, Switzerland nach diesem Ort suchen
Bestattung Martinez, Contra Costa County, California, United States of America nach diesem Ort suchen [32]
Tod 2. Mai 1949 Watsonville, Santa Cruz, California, USA nach diesem Ort suchen [33] [34] [35]
Tod 2. Mai 1949 Watsonville, Santa Cruz, California, USA nach diesem Ort suchen [36]
Tod 2. Mai 1949 Watsonville, Santa Cruz, California, USA nach diesem Ort suchen
Heirat 1. Juni 1915 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen
Heirat 28. Januar 1922 San Francisco, San Francisco, California, USA nach diesem Ort suchen
Heirat 2. April 1948 Santa Cruz, California, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1910 Goldfield, Esmeralda, Nevada, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1917 Eureka, California, USA nach diesem Ort suchen [38] [39]
Wohnen 1930 Tulare, San Joaquin, California, USA nach diesem Ort suchen [40] [41]
Wohnen 1935 Rural, Alameda, California nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1940 Santa Cruz, Santa Cruz, California, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen Aptos, California, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen Dürrenroth, Bern, Schweiz nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen San Francisco, California nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen Switzerland nach diesem Ort suchen [47]
Arrival 26. Oktober 1904 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [48] [49] [50]
Departure Februar 1913 Boulogne S M nach diesem Ort suchen [51]
Arrival Buenos Ayres nach diesem Ort suchen [52]
Departure Boulogne-sur-mer nach diesem Ort suchen [53]
Heirat 1912
Heirat 1. Juni 1915 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [54]
Heirat 1912
Heirat 1. Juni 1915 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1912
Frieda STEINER
Heirat Ehepartner Kinder
1912
Estefania Amalia STREIT NUNEZ

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Tulare, San Joaquin, California; Page: 12A; Enumeration District: 0086; FHL microfilm: 2339947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 USA, Sozialversicherungsindex, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York City Heiratsindizes, 1866-1938
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 US-Reisepassanträge, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 1312; Volume #: Roll 1312 - Certificates: 73250-73625, 29 Jul 1920-29 Jul 1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (4th Registration) for the State of California; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1904; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 17; Page Number: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Kalifornien, USA, Wählerregistrierungen, 1900-1968, California State Library; Sacramento, California; Great Register of Voters, 1900-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 California, Death Index, 1940-1997, Place: Santa Cruz; Date: 2 May 1949
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 Heiratsindex von Newspapers.com, 1800s -1999, Publication Date: 7/ Apr/ 1948; Publication Place: Santa Cruz, California, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/61613143/?article=a1b47a84-99ae-48c2-8fb2-f625490c9c79&focus=0.018194718,0.8954192,0.14460732,0.97279155&xid=3398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, Santa Cruz Sentinel; Publication Date: 6 Feb 1945; Publication Place: Santa Cruz, California, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/57083643/?article=22ee1276-73c8-4950-a835-09383d98751b&focus=0.020453583,0.36108962,0.14939246,0.43281898&xid=3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 US-Einzugsregistrierungskarten 1. Weltkrieg, 1917–1918, Registration State: California; Registration County: Solano County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Goldfield, Esmeralda, Nevada; Roll: T624_858; Page: 18A; Enumeration District: 0025; FHL microfilm: 1374871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Überseeische Auswanderungen aus der Schweiz, 1910-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Tulare, San Joaquin, California; Page: 12A; Enumeration District: 0086; FHL microfilm: 2339947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 US-Reisepassanträge, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 1312; Volume #: Roll 1312 - Certificates: 73250-73625, 29 Jul 1920-29 Jul 1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (4th Registration) for the State of California; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1904; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 17; Page Number: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 California, Death Index, 1940-1997, Place: Santa Cruz; Date: 2 May 1949
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 US-Einzugsregistrierungskarten 1. Weltkrieg, 1917–1918, Registration State: California; Registration County: Solano County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Goldfield, Esmeralda, Nevada; Roll: T624_858; Page: 18A; Enumeration District: 0025; FHL microfilm: 1374871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 Überseeische Auswanderungen aus der Schweiz, 1910-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 California, Death Index, 1940-1997, Place: Santa Cruz; Date: 2 May 1949
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Goldfield, Esmeralda, Nevada; Roll: T624_858; Page: 18A; Enumeration District: 0025; FHL microfilm: 1374871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 US-Einzugsregistrierungskarten 1. Weltkrieg, 1917–1918, Registration State: California; Registration County: Solano County
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Tulare, San Joaquin, California; Page: 12A; Enumeration District: 0086; FHL microfilm: 2339947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 Kalifornien, USA, Wählerregistrierungen, 1900-1968, California State Library; Sacramento, California; Great Register of Voters, 1900-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (4th Registration) for the State of California; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 Überseeische Auswanderungen aus der Schweiz, 1910-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 US-Reisepassanträge, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Roll #: 1312; Volume #: Roll 1312 - Certificates: 73250-73625, 29 Jul 1920-29 Jul 1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1904; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 17; Page Number: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 US-Volkszählung 1930, Year: 1930; Census Place: Tulare, San Joaquin, California; Page: 12A; Enumeration District: 0086; FHL microfilm: 2339947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
49 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1904; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 17; Page Number: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
50 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Goldfield, Esmeralda, Nevada; Roll: T624_858; Page: 18A; Enumeration District: 0025; FHL microfilm: 1374871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
51 Überseeische Auswanderungen aus der Schweiz, 1910-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
52 Überseeische Auswanderungen aus der Schweiz, 1910-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1904; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 17; Page Number: 123
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
54 New York City Heiratsindizes, 1866-1938
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Häring 2023
Beschreibung
Hochgeladen 2023-03-19 21:23:13.0
Einsender user's avatar André Häring
E-Mail andre.haering@bluewin.ch
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person