John Aulden ELLIOTT

John Aulden ELLIOTT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name John Aulden ELLIOTT [2]
Name John Auldin ELLIOTT [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 23. Mai 1891 Ogden, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Geburt 23. Mai 1891 Monton, New York nach diesem Ort suchen
Tod 10. August 1944 Spencerport, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1900 Hamlin, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1930 Spencerport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1935 Ogden, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1940 Ogden, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1920 Rochester Ward 15, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1. Juni 1915 Ogden, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1. Juni 1925 Ogden, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1942 Spencerport, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Heirat 10. Dezember 1913 Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
10. Dezember 1913
Monroe, New York, USA
Jennie L HAYES

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hamlin, Monroe, New York; Page: 7; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1241072
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hamlin, Monroe, New York; Page: 7; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1241072
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 New York, Death Index, 1852-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-197
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Monroe; Roll: 1818715; Draft Board: 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 04
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 7B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 14A; Enumeration District: 28-55
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Spencerport, Monroe, New York; Page: 5B; Enumeration District: 0231; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hamlin, Monroe, New York; Page: 7; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1241072
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 New York, Death Index, 1852-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-197
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Monroe; Roll: 1818715; Draft Board: 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 04
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 7B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 14A; Enumeration District: 28-55
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Spencerport, Monroe, New York; Page: 5B; Enumeration District: 0231; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 New York, Death Index, 1852-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hamlin, Monroe, New York; Page: 7; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1241072
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Spencerport, Monroe, New York; Page: 5B; Enumeration District: 0231; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 14A; Enumeration District: 28-55
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 14A; Enumeration District: 28-55
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 7B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 04
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Monroe; Roll: 1818715; Draft Board: 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-197
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kern Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2021-02-07 06:04:32.0
Einsender user's avatar Patricia Kern
E-Mail trckern@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person