Ward Herbert WEED

Ward Herbert WEED

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ward Herbert WEED [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 18. März 1915 Brockport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Bestattung Brockport, Monroe County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [21]
Tod 2. Juni 1960 Brockport, New York, USA nach diesem Ort suchen [22] [23]
Tod 2. Juni 1960 Kendall, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1930 Brockport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1. Juni 1915 Sweden, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen Kendall, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1920 Sweden, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1935 Brockport, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1940 Brockport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1993 und 2001 Hilton, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. Juni 1925 Sweden, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [31]
Heirat 29. November 1934 Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
29. November 1934
Monroe, New York, USA
Florence Evelyn PHELPS

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Sweden; County: Monroe; Page: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Sweden, Monroe, New York; Roll: T625_1120; Page: 11B; Enumeration District: 273
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0257; FHL microfilm: 2341183
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Sweden; County: Monroe; Page: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Sweden; County: Monroe; Page: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Sweden, Monroe, New York; Roll: T625_1120; Page: 11B; Enumeration District: 273
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0257; FHL microfilm: 2341183
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Sweden; County: Monroe; Page: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0257; FHL microfilm: 2341183
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Sweden; County: Monroe; Page: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Sweden, Monroe, New York; Roll: T625_1120; Page: 11B; Enumeration District: 273
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1940 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Sweden; County: Monroe; Page: 6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kern Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2021-02-07 06:04:32.0
Einsender user's avatar Patricia Kern
E-Mail trckern@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person