Donald Charles HEMMING

Donald Charles HEMMING

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Donald Charles HEMMING [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 12. Juni 1921 Clark Mills, Oneida, New York nach diesem Ort suchen [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
Bestattung Oriskany, Oneida County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [31] [32]
Tod 2. Mai 2005 Clark Mills, Oneida, New York nach diesem Ort suchen [33] [34] [35] [36] [37]
Wohnen Monroe, New York nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1994 und 2002 Whitesboro, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen Whitesboro, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1993 Whitesboro, NY nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1955 Rome, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1951 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Before 1951") New York nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1925 Whitestown, Oneida nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1935 Whitestown, Oneida, New York nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1940 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1930 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Departure Rosyth,sct nach diesem Ort suchen [48]
Arrival 18. September 1948 New York, New York nach diesem Ort suchen [49]
Heirat 14. Juni 1947 Waterbury Memorial Presbyterian Church, Oriskany, Oneida County, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
14. Juni 1947
Waterbury Memorial Presbyterian Church, Oriskany, Oneida County, New York, USA
Ruth V MACLOUGHLIN

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0174; FHL microfilm: 2341357
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 13
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S. Veterans' Gravesites, ca.1775-2006
Autor: National Cemetery Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Web: Obituary Daily Times Index, 1995-2016
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002, City: Whitesboro; State: New York; Year(s): 1994-2002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1948; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7655; Line: 2; Page Number: 150
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0174; FHL microfilm: 2341357
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 13
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 U.S. Veterans' Gravesites, ca.1775-2006
Autor: National Cemetery Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Web: Obituary Daily Times Index, 1995-2016
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1948; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7655; Line: 2; Page Number: 150
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S. Veterans' Gravesites, ca.1775-2006
Autor: National Cemetery Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 U.S. Veterans' Gravesites, ca.1775-2006
Autor: National Cemetery Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Web: Obituary Daily Times Index, 1995-2016
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 U.S. Phone and Address Directories, 1993-2002, City: Whitesboro; State: New York; Year(s): 1994-2002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 13
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0174; FHL microfilm: 2341357
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
48 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1948; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7655; Line: 2; Page Number: 150
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
49 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1948; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7655; Line: 2; Page Number: 150
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
50 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Schmidt
Beschreibung My family tree of the Odenwald region as of July 2020. Still a work in progress
Hochgeladen 2020-07-11 10:31:34.0
Einsender user's avatar Regina McAnally
E-Mail rmcana64@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person