Roger Spaar HAYES

Roger Spaar HAYES

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Roger Spaar HAYES [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 3. Oktober 1919 Winsted, Litchfield County, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Bestattung Winsted, Litchfield County, Connecticut, United States of America nach diesem Ort suchen [21]
Tod 19. März 1989 Winchester, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24] [25]
Wohnen Litchfield, Connecticut nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen Winchester, Litchfield, Connecticut nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1940 Winsted, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [28] [29]
Wohnen 1951 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Before 1951") Connecticut nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1920 Winchester, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1935 Winsted, Litchfield, Connecticut nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1930 Winchester, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [33]
Heirat 8. Juni 1946 Winchester, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [34]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
8. Juni 1946
Winchester, Connecticut, USA
Theresa Madeline O'BRIAN

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Page: 2A; Enumeration District: 0054; FHL microfilm: 2340005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Roll: T625_187; Page: 5A; Enumeration District: 232
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, The National Archives in St. Louis, Missouri; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Connecticut, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Page: 2A; Enumeration District: 0054; FHL microfilm: 2340005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Roll: T625_187; Page: 5A; Enumeration District: 232
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, The National Archives in St. Louis, Missouri; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Connecticut, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, The National Archives in St. Louis, Missouri; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Connecticut, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Roll: T625_187; Page: 5A; Enumeration District: 232
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Page: 2A; Enumeration District: 0054; FHL microfilm: 2340005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Schmidt
Beschreibung My family tree of the Odenwald region as of July 2020. Still a work in progress
Hochgeladen 2020-07-11 10:31:34.0
Einsender user's avatar Regina McAnally
E-Mail rmcana64@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person