John MCLANE

John MCLANE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name John MCLANE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt Oktober 1864 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Bestattung Underhill, Chittenden, Vermont, USA nach diesem Ort suchen
Tod nach 1940 New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1. Juni 1915 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1905 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1. Juni 1925 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1865 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1910 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1935 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1. April 1940 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1930 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1920 Clarence, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1900 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1870 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Heirat 1899 [33]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1899
Rosanna Lucina MCMULLEN

Quellenangaben

1 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 476A; Image: 396682; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 1A; Enumeration District: 0254; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T625_1110; Page: 7A; Enumeration District: 273; Image: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: 1435; Page: 3B; Enumeration District: 0385; Image: 37.0; FHL microfilm: 2341170
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 07; City: Clarence; : Erie; Page: 7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 01; City: Clarence; : Erie; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T627_2527; Page: 6B; Enumeration District: 15-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 5A; Enumeration District: 0255; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 09; City: Clarence; : Erie; Page: 18
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 476A; Image: 396682; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 1A; Enumeration District: 0254; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T625_1110; Page: 7A; Enumeration District: 273; Image: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: 1435; Page: 3B; Enumeration District: 0385; Image: 37.0; FHL microfilm: 2341170
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 07; City: Clarence; : Erie; Page: 7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 01; City: Clarence; : Erie; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T627_2527; Page: 6B; Enumeration District: 15-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 5A; Enumeration District: 0255; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 09; City: Clarence; : Erie; Page: 18
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 09; City: Clarence; : Erie; Page: 18
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 01; City: Clarence; : Erie; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 07; City: Clarence; : Erie; Page: 7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 5A; Enumeration District: 0255; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T627_2527; Page: 6B; Enumeration District: 15-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T627_2527; Page: 6B; Enumeration District: 15-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: 1435; Page: 3B; Enumeration District: 0385; Image: 37.0; FHL microfilm: 2341170
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Clarence, Erie, New York; Roll: T625_1110; Page: 7A; Enumeration District: 273; Image: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 1A; Enumeration District: 0254; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 476A; Image: 396682; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 1A; Enumeration District: 0254; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person