Katherine ROTHENBERGER

Katherine ROTHENBERGER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Katherine ROTHENBERGER [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 5. August 1871 Alzey, Hessen, Germany nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Bestattung 08NOV1934 New York nach diesem Ort suchen
Tod 6. November 1934 Brooklyn, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1900 Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1905 Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1. Juni 1915 New York, Kings, New York, United States nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1920 Brooklyn Assembly District 20, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. Juni 1925 Brooklyn, Kings, New York, United States nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Brooklyn, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 06NOV1934 Brooklyn, New York, USA nach diesem Ort suchen
Arrival 1889 [33] [34]
Arrival 1890 [35]
Arrival 1. April 1891 New York, New York nach diesem Ort suchen [36] [37] [38]
Arrival 5. November 1928 New York, New York nach diesem Ort suchen [39]
Death 7. November 1934 Brooklyn, New York nach diesem Ort suchen [40]
Departure Antwerp, Belgium nach diesem Ort suchen [41] [42] [43]
Departure Bremen, Germany nach diesem Ort suchen [44]
Heirat 30MAR1894 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [45]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
30MAR1894
Manhattan, New York, USA
Rudolf George REINHARD

Quellenangaben

1 New York, New York, U.S., Index to Death Certificates, 1862-1948, New York City Department of Records & Information Services; New York City, New York; New York City Death Certificates; Borough: Brooklyn; Year: 1934
Autor: Ancestry.com
2 New York, New York, U.S., Index to Birth Certificates, 1866-1909, New York City Department of Records & Information Services; New York City, New York; New York City Birth Certificates
Autor: Ancestry.com
3 New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Page: 15B; Enumeration District: 0399
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 10 E.D. 18; City: Manhattan; County: New York; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 19; Assembly District: 20; City: New York; County: Kings; Page: 31
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 20, Kings, New York; Roll: T625_1177; Page: 3B; Enumeration District: 1300
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 11; Assembly District: 20; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 4; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York Port, Ship Images, 1851-1891
11 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 2; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4377; Line: 14; Page Number: 247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 15; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1241092
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Page: 15B; Enumeration District: 0399
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 10 E.D. 18; City: Manhattan; County: New York; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 19; Assembly District: 20; City: New York; County: Kings; Page: 31
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 20, Kings, New York; Roll: T625_1177; Page: 3B; Enumeration District: 1300
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 11; Assembly District: 20; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 4; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 New York Port, Ship Images, 1851-1891
23 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 2; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4377; Line: 14; Page Number: 247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 15; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1241092
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 15; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1241092
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 10 E.D. 18; City: Manhattan; County: New York; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 19; Assembly District: 20; City: New York; County: Kings; Page: 31
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 20, Kings, New York; Roll: T625_1177; Page: 3B; Enumeration District: 1300
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 11; Assembly District: 20; City: Brooklyn; County: Kings; Page: 14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Page: 15B; Enumeration District: 0399
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Page: 15B; Enumeration District: 0399
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Brooklyn Assembly District 20, Kings, New York; Roll: T625_1177; Page: 3B; Enumeration District: 1300
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 15; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1241092
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 4; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 New York Port, Ship Images, 1851-1891
38 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 2; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4377; Line: 14; Page Number: 247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Newspapers.com - Times Union - 7 Nov 1934 - Page 22, 7 Nov 1934
Angaben zur Veröffentlichung: Times Union
41 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 4; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 New York Port, Ship Images, 1851-1891
43 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1891; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 564; Line: 2; List Number: 400
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1928; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4377; Line: 14; Page Number: 247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Adams Family Ancestry
Beschreibung
Hochgeladen 2023-12-13 17:28:32.0
Einsender user's avatar Ellen De Carlo
E-Mail ellendecarlo1@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person