János SLADEK

János SLADEK

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name János SLADEK [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 13. Dezember 1881 Griselstein, Burgenland, Austria nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Bestattung 1945 Saint Mary Cemetery, New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [28]
Taufe 23. Dezember 1881 Gyanafalva, Vas, Hungary nach diesem Ort suchen [29]
Tod 26. Dezember 1945 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [30] [31] [32] [33]
Einbürgerung 17. April 1929 [34]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1940 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [37]
Arrival 13. Oktober 1909 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Heirat 26. November 1925 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [39] [40] [41]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
26. November 1925
New Britain, Hartford, Connecticut, USA
Anna BAHR

Quellenangaben

1 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Connecticut; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Series Number: M1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 U.S., Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), The National Archives in Washington, DC; Washington, DC; Index to New England Naturalization Petitions, 1791-1906 (M1299); Microfilm Serial: M1299; Microfilm Roll: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: m-t0627-00504; Page: 9A; Enumeration District: 2-114
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Connecticut; Registration County: Hartford
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 Hungary, Select Catholic Church Records, 1636-1895
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Connecticut, U.S., Federal Naturalization Records, 1790-1996, National Archives At Boston; Waltham, Massachusetts; ARC Title: Petitions and Records of Naturalization, 6/6/1917 - 9/26/1939; NAI Number: 4526781; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Connecticut, U.S., Federal Naturalization Records, 1790-1996
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Hartford Courant; Publication Date: 6 Jun 1977; Publication Place: Hartford, Connecticut, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/240741577/?article=598e0c5e-0692-49ea-92cd-8a0c7ef70b92&focus=0.13236482,0.82813317,0.2568003,0.9733602&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 WEB: Connecticut Death Records, 1897-1968, State Vital Records Office; Hartford, Connecticut; Connecticut Vital Records — Index of Deaths, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: m-t0627-00504; Page: 9A; Enumeration District: 2-114
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Hungary, Select Catholic Church Records, 1636-1895
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Connecticut, U.S., Federal Naturalization Records, 1790-1996
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Hartford Courant; Publication Date: 6 Jun 1977; Publication Place: Hartford, Connecticut, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/240741577/?article=598e0c5e-0692-49ea-92cd-8a0c7ef70b92&focus=0.13236482,0.82813317,0.2568003,0.9733602&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives At St. Louis; St. Louis, Missouri; World War Ii Draft Cards (Fourth Registration) For the State of Connecticut; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 147; Series Number: M1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: m-t0627-00504; Page: 9A; Enumeration District: 2-114
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 Connecticut, U.S., Federal Naturalization Records, 1790-1996, National Archives At Boston; Waltham, Massachusetts; ARC Title: Petitions and Records of Naturalization, 6/6/1917 - 9/26/1939; NAI Number: 4526781; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Connecticut, U.S., Federal Naturalization Records, 1790-1996
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Hungary, Select Catholic Church Records, 1636-1895
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 WEB: Connecticut Death Records, 1897-1968, State Vital Records Office; Hartford, Connecticut; Connecticut Vital Records — Index of Deaths, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S., Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), The National Archives in Washington, DC; Washington, DC; Index to New England Naturalization Petitions, 1791-1906 (M1299); Microfilm Serial: M1299; Microfilm Roll: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Connecticut; Registration County: Hartford
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: m-t0627-00504; Page: 9A; Enumeration District: 2-114
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: m-t0627-00504; Page: 9A; Enumeration District: 2-114
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 Connecticut, U.S., Federal Naturalization Records, 1790-1996, National Archives At Boston; Waltham, Massachusetts; ARC Title: Petitions and Records of Naturalization, 6/6/1917 - 9/26/1939; NAI Number: 4526781; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person