Genovefa OTT

Genovefa OTT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Genovefa OTT [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1. Juli 1846 Baden-Württemberg, Germany nach diesem Ort suchen [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
Tod 22. September 1911 Kenton County, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33] [34] [35]
Wohnen 1880 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [39]
Arrival 1868 New York, USA nach diesem Ort suchen [40] [41] [42]
Arrival 29. August 1900 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Departure Bremen, Bremen, Germany nach diesem Ort suchen [44]
Departure [45]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 426; Family History Film: 1254426; Page: 455A; Enumeration District: 123; Image: 0131
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1868; Arrival: New York; Microfilm Serial: M237; Microfilm Roll: M237_299; Line: 29; List Number: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1900; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_146; Line: 7; Page Number: 130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 426; Family History Film: 1254426; Page: 455A; Enumeration District: 123; Image: 0131
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1868; Arrival: New York; Microfilm Serial: M237; Microfilm Roll: M237_299; Line: 29; List Number: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1900; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_146; Line: 7; Page Number: 130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 426; Family History Film: 1254426; Page: 455A; Enumeration District: 123; Image: 0131
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1868; Arrival: New York; Microfilm Serial: M237; Microfilm Roll: M237_299; Line: 29; List Number: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1900; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_146; Line: 7; Page Number: 130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Covington, Kenton, Kentucky; Roll: 426; Family History Film: 1254426; Page: 455A; Enumeration District: 123; Image: 0131
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1900; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_146; Line: 7; Page Number: 130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1868; Arrival: New York; Microfilm Serial: M237; Microfilm Roll: M237_299; Line: 29; List Number: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: 535; Page: 10B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1240535
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington Ward 4, Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 12B; Enumeration District: 0101; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1900; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_146; Line: 7; Page Number: 130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1900; Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_146; Line: 7; Page Number: 130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1868; Arrival: New York; Microfilm Serial: M237; Microfilm Roll: M237_299; Line: 29; List Number: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person