Margaretha BÄHR

Margaretha BÄHR

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Margaretha BÄHR [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 23. Juli 1834 Katholisch,Goecklingen,Pfalz,Bavaria nach diesem Ort suchen [11]
Geburt 23. Juli 1834 Göcklingen, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Tod 24. November 1910 Manhattan, New York, USA nach diesem Ort suchen [20] [21]
Wohnen 1870 New York Ward 11 District 1, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1880 New York City, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1900 Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1905 Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Arrival 22. Februar 1856 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Departure Le Havre, France nach diesem Ort suchen [27]
Heirat 1857 [28]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1857
Anton BENGERT
Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: New York Ward 11 District 1, New York, New York; Roll: M593_986; Page: 532B; Family History Library Film: 552485
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New York, Wills and Probate Records, 1659-1999, Record of Wills, 1665-1916; Index to Wills, 1662-1923 (New York County); Author: New York. Surrogate's Court (New York County); Probate Place: New York, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 30 E.D. 15; City: Manhattan; County: New York; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1856; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 46; List Number: 82
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 873; Page: 166A; Enumeration District: 145
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 22; Enumeration District: 0819; FHL microfilm: 1241117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 New York, New York, Index to Death Certificates, 1862-1948, New York City Department of Records & Information Services; New York City, New York; New York City Death Certificates
Autor: Ancestry.com
11 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: New York Ward 11 District 1, New York, New York; Roll: M593_986; Page: 532B; Family History Library Film: 552485
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 30 E.D. 15; City: Manhattan; County: New York; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1856; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 46; List Number: 82
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 873; Page: 166A; Enumeration District: 145
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 22; Enumeration District: 0819; FHL microfilm: 1241117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 New York, New York, Index to Death Certificates, 1862-1948, New York City Department of Records & Information Services; New York City, New York; New York City Death Certificates
Autor: Ancestry.com
20 New York, Wills and Probate Records, 1659-1999, Record of Wills, 1665-1916; Index to Wills, 1662-1923 (New York County); Author: New York. Surrogate's Court (New York County); Probate Place: New York, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 New York, New York, Extracted Death Index, 1862-1948
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: New York Ward 11 District 1, New York, New York; Roll: M593_986; Page: 532B; Family History Library Film: 552485
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: New York City, New York, New York; Roll: 873; Page: 166A; Enumeration District: 145
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 22; Enumeration District: 0819; FHL microfilm: 1241117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 30 E.D. 15; City: Manhattan; County: New York; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1856; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 46; List Number: 82
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1856; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 46; List Number: 82
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Page: 22; Enumeration District: 0819; FHL microfilm: 1241117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Ahnen
Beschreibung Für Ergänzungen und Berichtigungen bin ich sehr dankbar. Bitte unter: rebecca.mert@gmx.de
Hochgeladen 2023-12-17 17:49:22.0
Einsender user's avatar Rebecca Mert
E-Mail rebecca.mert@gmx.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person