Ernst KELLER

Ernst KELLER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ernst KELLER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Religionszugehörigkeit rk

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 16. März 1911 Rastatt, Baden-Württemberg,Deutschland nach diesem Ort suchen [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Tod 13. Juni 1975 New York City, New York nach diesem Ort suchen
Wohnen 1940 New York, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [14] [15]
Wohnen 1935 Rural, Germany nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen 1975 11106, Long Island City, Queens, New York, USA nach diesem Ort suchen
Tod 12. Juli 1975 New York, New York nach diesem Ort suchen [17]
Beruf 1939 New York, Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnsitz 1939 Manhattan, New York City (New York City (All Boroughs)), New York, USA nach diesem Ort suchen
Heiratslizens 4. Februar 1939 Manhattan, New Yor, New York, USA nach diesem Ort suchen
Abreise 8. Juni 1928 Hamburg, Deutschland nach diesem Ort suchen [18]
Ankunft 18. Juni 1928 Ellis Island, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Heirat 19. Februar 1939 New York, Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Trauzeugen 1. Februar 1939 Manhatten, New York City, New York nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
19. Februar 1939
New York, Manhattan, New York, New York, USA
Rose SCHUMM

Notizen zu dieser Person

Daily News, New York vom 13.6.1975 KELLER Ernst. Die Offiziere und Mitglieder der Eisenarbeitergewerkschaft 455 sprechen der Familie Ernst Keller ihr tiefstse Mitgefühl aus. Bruder Keller war bekannt und respektiert in der gesamten Eisen & Metallindustrie als engagierte und humaner Mensch, der die besten Werte der Zivilisation auf seine tägliche Lite angewendet hat.

Quellenangaben

1 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1943, National Archives and Records Administration; Washington, DC; NAI Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Courts of t
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2013;;
2 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2011;;
3 New York, Naturalization Records, 1882-1944
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;;
4 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1934; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 8; Page Number: 146
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;;
5 New York, New York, Marriage License Indexes, 1907-2018, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
6 New York, Naturalization Records, 1882-1944, The National Archives and Records Administration; Washington, D.C.; Petitions for Naturalization from the U.S. District Court for the Southern District of New York, 1897-1944; Series: M1972; Roll: 1445
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
7 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02493; Page: 12A; Enumeration District: 3-1327
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;;
8 New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1943, National Archives and Records Administration; Washington, DC; NAI Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Courts of t
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2013;;
9 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2011;;
10 New York, Naturalization Records, 1882-1944
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;;
11 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1934; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 8; Page Number: 146
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;;
12 New York, Naturalization Records, 1882-1944, The National Archives and Records Administration; Washington, D.C.; Petitions for Naturalization from the U.S. District Court for the Southern District of New York, 1897-1944; Series: M1972; Roll: 1445
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
13 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02493; Page: 12A; Enumeration District: 3-1327
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;;
14 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2011;;
15 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02493; Page: 12A; Enumeration District: 3-1327
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;;
16 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: m-t0627-02493; Page: 12A; Enumeration District: 3-1327
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;;
17 Newspapers.com - Daily News - 1975-07-12 - Page 106, 1975-07-12
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Daily News; Location: New York, New York; Date: 1975-07-12;
18 Hamburg Passenger Liste, Abfahrt am 8. Juni 1928 von Hamburg nach New York über Boulogne, Southhamton mit dem Schiff Hamburg in der 2. Klasse, Listen-Nr. 17.
19 Hamburg Passenger Liste, Ankunft am 18. Juni 1928 in Ellis Islan, New York mit dem Schiff HAMBURG nach 10 Tagen.
20 New York, New York, Marriage License Indexes, 1907-2018, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Die+M��llerfamilie+WITTMANN+zu+Behringersm��hle
Beschreibung Eine+genealogische+Reise+durch+420+Jahre
Hochgeladen 2023-01-04 11:58:56.0
Einsender user's avatar Helmut Wittmann
E-Mail h.wittmann@live.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person