Ethel May ELLIOTT

Ethel May ELLIOTT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ethel May ELLIOTT [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 16. Januar 1902 Hamlin, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Tod 31. Juli 1975 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [15]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester Ward 15, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen 1930 Gates, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1920 Rochester Ward 15, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1. Juni 1915 Ogden, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1910 Ogden, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Heirat 20. Juni 1922 Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
20. Juni 1922
Monroe, New York, USA
Byron K HAYES

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: T624_988; Page: 10A; Enumeration District: 0026; FHL microfilm: 1375001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 10B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Gates, Monroe, New York; Page: 17A; Enumeration District: 0208; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 069-52-0924; Issue State: New York; Issue Date: 1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 15; County: Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: T624_988; Page: 10A; Enumeration District: 0026; FHL microfilm: 1375001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 10B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Gates, Monroe, New York; Page: 17A; Enumeration District: 0208; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 069-52-0924; Issue State: New York; Issue Date: 1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 15; County: Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 069-52-0924; Issue State: New York; Issue Date: 1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 15; County: Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Gates, Monroe, New York; Page: 17A; Enumeration District: 0208; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 10B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: T624_988; Page: 10A; Enumeration District: 0026; FHL microfilm: 1375001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kern Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2021-02-07 06:04:32.0
Einsender user's avatar Patricia Kern
E-Mail trckern@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person