Carl S ELLIOTT

Carl S ELLIOTT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Carl S ELLIOTT [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Name Samuel Carl ELLIOTT

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 25. Februar 1904 Hamlin, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Tod März 1977 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19] [20]
Wohnen 1932 Rochester, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1930 Greece, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen Rochester, New York, New nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1935 Greece, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1940 Greece, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1920 Rochester Ward 15, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1. Juni 1915 Ogden, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester Ward 15, Monroe, New York, United States nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1910 Ogden, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Heirat 11. Juni 1928 Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
11. Juni 1928
Monroe, New York, USA
Mary Thelma FAIRBANKS

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: T624_988; Page: 10A; Enumeration District: 0026; FHL microfilm: 1375001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 15; County: Monroe; Page: 28
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 10B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 104-10-1073; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greece, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02678; Page: 10B; Enumeration District: 28-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Obituary Collection, 1930-2018, Publication Date: 01/ 11/ 2015; Publication Place: City, New York, USA; URL: http://www.tributes.com/obituary/print_selections/10195086?type=1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Greece, Monroe, New York; Page: 18A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 2341181
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Democrat and Chronicle; Publication Date: 19 Feb 1953; Publication Place: Rochester, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/136418265/?article=5eb1574b-feeb-4be6-a40
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: T624_988; Page: 10A; Enumeration District: 0026; FHL microfilm: 1375001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 15; County: Monroe; Page: 28
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 10B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 104-10-1073; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greece, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02678; Page: 10B; Enumeration District: 28-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Greece, Monroe, New York; Page: 18A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 2341181
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 104-10-1073; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 U.S., Obituary Collection, 1930-2018, Publication Date: 01/ 11/ 2015; Publication Place: City, New York, USA; URL: http://www.tributes.com/obituary/print_selections/10195086?type=1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Greece, Monroe, New York; Page: 18A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 2341181
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S., Obituary Collection, 1930-2018, Publication Date: 01/ 11/ 2015; Publication Place: City, New York, USA; URL: http://www.tributes.com/obituary/print_selections/10195086?type=1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greece, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02678; Page: 10B; Enumeration District: 28-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Greece, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02678; Page: 10B; Enumeration District: 28-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 10B; Enumeration District: 174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 05; City: Ogden; County: Monroe; Page: 09
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 15; County: Monroe; Page: 28
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Ogden, Monroe, New York; Roll: T624_988; Page: 10A; Enumeration District: 0026; FHL microfilm: 1375001
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kern Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2021-02-07 06:04:32.0
Einsender user's avatar Patricia Kern
E-Mail trckern@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person