Mary Ann SCHICKER

Mary Ann SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Mary Ann SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 17. März 1887 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung 29. Oktober 1971 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Tod 25. Oktober 1971 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1936 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27] [28]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31] [32]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Heirat 31. Dezember 1904 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
31. Dezember 1904
Rochester, Monroe, New York, USA
Louis Joseph TAYLERT

Quellenangaben

1 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
15 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 Charts from Richard Schicker, sent to me by Martin and Gladys Schicker, 1996
24 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 33
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 6A; Enumeration District: 0211; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 14B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 6A; Enumeration District: 185; Image: 161.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
37 Diocese of Rochester records on microfilm at Nazareth College Library, Roll, 6, Item 19, Most Holy Redeemer Church, Marriages, p322

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person