Raymond Otto SCHICKER

Raymond Otto SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Raymond Otto SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 29. Juni 1914 [11]
Geburt 29. Juni 1914 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Bestattung 4. Januar 1992 Byron, Genesee, New York, USA nach diesem Ort suchen [23] [24]
Tod 1. Januar 1992 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25] [26] [27] [28]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1986 Phoenix, Maricopa, Arizona, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1992 [35]
Comment 1 [36]
Event 3 1. April 1928 [37]
Comment 2 1942 [38]
Comment 3 1944 [39]
Comment 4 1947 [40]
Heirat 25. Januar 1941 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
25. Januar 1941
Rochester, Monroe, New York, USA
Louise Margaret MAXSON

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 9A; Enumeration District: 256; Image: 912
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 04
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-352A
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-05-2051; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 19A; Enumeration District: 0188; Image: 433.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 U.S. Public Records Index, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
10 New York, New York National Guard Service Cards, 1917-1954, New York State Archives; Albany, New York; Collection: New York, New York National Guard Service Cards, 1917-1954; Series: B2001; Film Number: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
11 Concordia Lutheran Church Records, microfilm at Rundel Library, Rochester NY #5, Baptism p180 #649
12 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 9A; Enumeration District: 256; Image: 912
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 International Genealogical Index(R), downloaded 28 May 2007
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
14 Concordia Lutheran Church Records, microfilm at Rundel Library, Rochester NY #5, Baptisms p180 #649
15 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 04
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-352A
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-05-2051; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 19A; Enumeration District: 0188; Image: 433.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 U.S. Public Records Index, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, New York National Guard Service Cards, 1917-1954, New York State Archives; Albany, New York; Collection: New York, New York National Guard Service Cards, 1917-1954; Series: B2001; Film Number: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
23 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 Raymond O. Schicker, Obit Rochester Democrat & Chronicle, Jan 3 1992
25 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-05-2051; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 Raymond O. Schicker, Obit Rochester Democrat & Chronicle, Jan 3 1992
29 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 9A; Enumeration District: 256; Image: 912
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 04
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 U.S. Public Records Index, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 19A; Enumeration District: 0188; Image: 433.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-352A
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-352A
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 Raymond O. Schicker, Obit Rochester Democrat & Chronicle, Jan 3 1992
36 Raymond O. Schicker, Obit Rochester Democrat & Chronicle, Jan 3 1992
37 Concordia Lutheran Church Records, microfilm at Rundel Library, Rochester NY #5, Confirmations p587
38 Concordia Lutheran Church Records, microfilm at Rundel Library, Rochester NY #5, Baptisms p262
39 Concordia Lutheran Church Records, microfilm at Rundel Library, Rochester NY #5, Baptisms p266
40 Concordia Lutheran Church Records, microfilm at Rundel Library, Rochester NY #5, Baptisms p272
41 International Genealogical Index(R), downloaded 28 May 2007
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person