Catherine SCHICKER

Catherine SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Catherine SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Name Katherine SCHICKER [17]
Name Katherine SCHICKER [18]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt November 1887 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
Tod April 1962 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27] [28]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1919 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1916 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35] [36]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen [40]
Comment 1 1928 [41]
Comment 2 1928 [42]
Heirat 30. September 1914 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43] [44] [45] [46]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
30. September 1914
Rochester, Monroe, New York, USA
Robert William PANNEITZ

Quellenangaben

1 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 5A; Enumeration District: 0210; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 4A; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 05; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 95
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
15 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
16 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
17 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 5A; Enumeration District: 0210; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1900 US Census, NY, Monroe Co, Rochester, Ward 17 p 191A, 153 Alphonse St
21 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 4A; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 05; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 95
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
27 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 05; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 95
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 4A; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
38 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 5A; Enumeration District: 0210; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
40 Monroe Co NY Surrogate Court Record #1928-1142, Catherine Schicker
41 Monroe Co NY Surrogate Court Record #1928-1142, Catherine Schicker
42 Monroe Co NY Surrogate Court Record #1928-1142, Catherine Schicker
43 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
44 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
45 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
46 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person