Paul Francis SCHICKER

Paul Francis SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Paul Francis SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 22. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Bestattung Webster, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Tod 27. Januar 1996 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23] [24] [25] [26]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1986 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Heirat 1934

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1934
Vivian Virginia FERGE

Notizen zu dieser Person

Social Security Death Index about Paul F. Schicker Name: Paul F. Schicker SSN: 104-09-1539 Last Residence: 14622 Rochester, Monroe, New York, USA of America Born: 22 Jun 1915 Died: 27 Jan 1996 State (Year) SSN issued: New York (Before 1951 )

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 16; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 18; : Monroe; Page: 27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 8A; Enumeration District: 213; Image: 1008
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1452; Page: 3A; Enumeration District: 0129; Image: 518.0; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 16A; Enumeration District: 65-240
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-09-1539; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 U.S. Public Records Index, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
12 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 16; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 18; : Monroe; Page: 27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 Charts from Richard Schicker, sent to me by Gladys and Martin Schicker
14 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 8A; Enumeration District: 213; Image: 1008
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1452; Page: 3A; Enumeration District: 0129; Image: 518.0; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 16A; Enumeration District: 65-240
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-09-1539; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 U.S. Public Records Index, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
22 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 104-09-1539; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 obit Rochester Times Union Jan 1996
27 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 16; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 18; : Monroe; Page: 27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S. Public Records Index, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 16A; Enumeration District: 65-240
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 16A; Enumeration District: 65-240
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1452; Page: 3A; Enumeration District: 0129; Image: 518.0; FHL microfilm: 2341187
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 8A; Enumeration District: 213; Image: 1008
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person