Agnes Eleanor FOUSSE

Agnes Eleanor FOUSSE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Agnes Eleanor FOUSSE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 3. Juni 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [9] [10] [11] [12] [13]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [14]
Tod 31. Dezember 1995 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [15] [16] [17]
Wohnen 1960 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Heirat 9. August 1941 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
9. August 1941
Rochester, Monroe, New York, USA
John HRYUNAK

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 3B; Enumeration District: 0172; Image: 707.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 31
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 102-12-0627; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
8 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
9 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 3B; Enumeration District: 0172; Image: 707.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 31
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 102-12-0627; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
14 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 102-12-0627; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
17 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
18 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 31
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 3B; Enumeration District: 0172; Image: 707.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person