Frederick Elmer CULVER

Frederick Elmer CULVER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Frederick Elmer CULVER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt September 1897 Groton, Tompkins, New York, USA nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Tod 11. Januar 1961 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1905 Murray, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [26] [27]
Wohnen Penn Yan, Yates, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1910 Penn Yan, Yates, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1920 St Clair, St Clair, Michigan, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1900 Groton, Tompkins, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Heirat 17. Mai 1923 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36] [37]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
17. Mai 1923
Rochester, Monroe, New York, USA
Lillian Margaret SCHICKER

Quellenangaben

1 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 17A; Enumeration District: 0084; Image: 464.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5B; Enumeration District: 65-167
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 03; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 18
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York State Censuses, 1880, 1892, 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Murray; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
9 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Groton, Tompkins, New York; Roll: 1168; Page: 5A; Enumeration District: 0145; FHL microfilm: 1241168
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
10 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: St Clair, St Clair, Michigan; Roll: T625_795; Page: 6A; Enumeration District: 132
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
11 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Penn Yan Ward 2, Yates, New York; Roll: T624_1075; Page: 16A; Enumeration District: 0179; FHL microfilm: 1375088
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
12 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Yates; Roll: 1819339
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
13 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 17A; Enumeration District: 0084; Image: 464.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5B; Enumeration District: 65-167
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 03; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 18
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 New York State Censuses, 1880, 1892, 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Murray; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Groton, Tompkins, New York; Roll: 1168; Page: 5A; Enumeration District: 0145; FHL microfilm: 1241168
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
21 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: St Clair, St Clair, Michigan; Roll: T625_795; Page: 6A; Enumeration District: 132
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
22 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Penn Yan Ward 2, Yates, New York; Roll: T624_1075; Page: 16A; Enumeration District: 0179; FHL microfilm: 1375088
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
23 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Yates; Roll: 1819339
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
24 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 New York State Censuses, 1880, 1892, 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Murray; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Yates; Roll: 1819339
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
29 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 03; Assembly District: 03; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 18
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Penn Yan Ward 2, Yates, New York; Roll: T624_1075; Page: 16A; Enumeration District: 0179; FHL microfilm: 1375088
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
31 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: St Clair, St Clair, Michigan; Roll: T625_795; Page: 6A; Enumeration District: 132
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
32 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Groton, Tompkins, New York; Roll: 1168; Page: 5A; Enumeration District: 0145; FHL microfilm: 1241168
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
33 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5B; Enumeration District: 65-167
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5B; Enumeration District: 65-167
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 17A; Enumeration District: 0084; Image: 464.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person