Joseph EISMANN

Joseph EISMANN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Joseph EISMANN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Beruf 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 15. Februar 1863 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Geburt 12. Februar 1863 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Tod 15. September 1956 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1. Juni 1875 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1926 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1921 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1870 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1880 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Wohnen 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [52]
Wohnen 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [53]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [54]
Wohnen 1929 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [55]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [56]
Wohnen 1865 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [57]
Wohnen 1. Juni 1875 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [58]
Wohnen 1870 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [59]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [60]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [61]
Wohnen 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [62]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [63]
Wohnen 1880 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [64]
arrest 2 29. Februar 1908 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [65]
arrest 31. März 1952 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [66]
Article Arrest 26. Januar 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [67]
Obituary 17. September 1956 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [68]
Madison Hotel Article Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [69]
Madison Hotel Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [70]
Madison Hotel Article Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [71]
Madison Hotel Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [72]
Madison Hotel Article Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [73]
Madison Hotel Article Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [74]
Madison Hotel Article Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [75]
Madison Hotel Article Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [76]
Madison Hotel Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [77]
Heirat 21. April 1903 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
21. April 1903
Rochester, Monroe, New York, USA
Anna J. HOEPFL

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, Jan 2, 1906 - Mar 31, 1925; Roll #: 83; Volume #: Roll 0083 - Certificates: 3426-4325, 26 Apr 1909-05 May 1909
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 10A; Enumeration District: 131; Image: 781
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 3A; Enumeration District: 0066; Image: 1015.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2845; Page: 2A; Enumeration District: 65-121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 862; Family History Film: 1254862; Page: 16D; Enumeration District: 073; Image: 0508
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387474; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
19 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 26 Mar 2000 - Page 1, 26 Mar 2000
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
20 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 17 Oct 1997 - Page 2, 17 Oct 1997
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
21 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 19 Sep 2000 - Page 1, 19 Sep 2000
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
22 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 9 Oct 1904 - Page 18, 9 Oct 1904
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
23 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 12 Feb 1951 - Page 12, 12 Feb 1951
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
24 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
25 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, Jan 2, 1906 - Mar 31, 1925; Roll #: 83; Volume #: Roll 0083 - Certificates: 3426-4325, 26 Apr 1909-05 May 1909
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 10A; Enumeration District: 131; Image: 781
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 3A; Enumeration District: 0066; Image: 1015.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2845; Page: 2A; Enumeration District: 65-121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 862; Family History Film: 1254862; Page: 16D; Enumeration District: 073; Image: 0508
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
37 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387474; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
44 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
45 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, Jan 2, 1906 - Mar 31, 1925; Roll #: 83; Volume #: Roll 0083 - Certificates: 3426-4325, 26 Apr 1909-05 May 1909
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
46 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
47 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
48 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387474; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
49 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 862; Family History Film: 1254862; Page: 16D; Enumeration District: 073; Image: 0508
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
50 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
51 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2845; Page: 2A; Enumeration District: 65-121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
52 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2845; Page: 2A; Enumeration District: 65-121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
53 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
54 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 3A; Enumeration District: 0066; Image: 1015.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
55 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
56 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 10A; Enumeration District: 131; Image: 781
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
57 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
58 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
59 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387474; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
60 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 3A; Enumeration District: 0066; Image: 1015.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
61 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 10A; Enumeration District: 131; Image: 781
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
62 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
63 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2845; Page: 2A; Enumeration District: 65-121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
64 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 862; Family History Film: 1254862; Page: 16D; Enumeration District: 073; Image: 0508
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
65 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 29 Feb 1908 - Page 15, 29 Feb 1908
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
66 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 31 Mar 1952 - Page 13, 31 Mar 1952
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
67 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 26 Jan 1930 - Page 19, 26 Jan 1930
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
68 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 17 Sep 1956 - Page 15, 17 Sep 1956
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
69 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 5 Feb 1998 - Page 9, 5 Feb 1998
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
70 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 7 Jan 1998 - Page 13, 7 Jan 1998
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
71 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 4 Nov 1997 - Page 8, 4 Nov 1997
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
72 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 26 Mar 2000 - Page 12, 26 Mar 2000
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
73 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 19 Sep 2000 - Page 8, 19 Sep 2000
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
74 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 9 Oct 2001 - Page 13, 9 Oct 2001
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
75 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 19 Oct 2001 - Page 11, 19 Oct 2001
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
76 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 26 Feb 2002 - Page 45, 26 Feb 2002
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;
77 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 17 Oct 1997 - Page 2, 17 Oct 1997
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person