Eulalia Theresa HILBERT

Eulalia Theresa HILBERT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Eulalia Theresa HILBERT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 18. September 1903 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Tod 20. September 1991 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19] [20]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Edmund T LAVIGNE

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 073-05-2635; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
12 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 073-05-2635; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 073-05-2635; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person