Edward J HILBERT

Edward J HILBERT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Edward J HILBERT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 16. Mai 1891 Brockport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Tod 15. August 1972 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28] [29]
Wohnen 1933 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1942 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Heirat 28. März 1932 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. März 1932
Rochester, Monroe, New York, USA
Mary Ann CONNERS

Quellenangaben

1 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 713-05-6800; Issue State: Railroad Board (Issued Through); Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 12B; Enumeration District: 65-251
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818715; Draft Board: 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
15 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 05; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
16 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 713-05-6800; Issue State: Railroad Board (Issued Through); Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 12B; Enumeration District: 65-251
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818715; Draft Board: 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 05; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
27 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 713-05-6800; Issue State: Railroad Board (Issued Through); Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 05; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 24
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
32 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818715; Draft Board: 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; Draft Registration Cards for Fourth Registration for New York State, 04/27/1942 - 04/27/1942; NAI Number: 2555973; Record Group Title: Records of the Selective Service System; Record Group Number: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 12B; Enumeration District: 65-251
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2849; Page: 12B; Enumeration District: 65-251
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
39 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
41 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person