Carl Frederick WILD

Carl Frederick WILD

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Carl Frederick WILD [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 5. Januar 1877 Germany nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [24] [25]
Tod 20. Dezember 1952 South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1931 Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1935 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1. April 1940 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1930 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1920 Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [35]
Arrival 1881 [36]
Arrival 1880 [37]
Heirat 12. Oktober 1916 Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [38] [39]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
12. Oktober 1916
Hartford, Connecticut, USA
Sadie Eloise FURREY

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Connecticut; Registration : Hartford; Roll: 1561894; Draft Board: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 Source Citation: Year: 1920;Census Place: Hartford Ward 10, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 15B; Enumeration District: 127; Image: 536
3 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Hartford Ward 10, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 15B; Enumeration District: 127; Image: 537
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 262; Page: 11A; Enumeration District: 0114; Image: 68.0; FHL microfilm: 2339997
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_502; Page: 8A; Enumeration District: 2-54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
13 Virginia, Marriage Records, 1936-2014, Virginia Department of Health; Richmond, Virginia; Virginia Marriages, 1936-2014; Roll: 101144358
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
14 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019;
15 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Connecticut; Registration : Hartford; Roll: 1561894; Draft Board: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 Source Citation: Year: 1920;Census Place: Hartford Ward 10, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 15B; Enumeration District: 127; Image: 536
17 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Hartford Ward 10, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 15B; Enumeration District: 127; Image: 537
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 262; Page: 11A; Enumeration District: 0114; Image: 68.0; FHL microfilm: 2339997
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_502; Page: 8A; Enumeration District: 2-54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
24 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
26 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
29 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Connecticut; Registration : Hartford; Roll: 1561894; Draft Board: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_502; Page: 8A; Enumeration District: 2-54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_502; Page: 8A; Enumeration District: 2-54
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 262; Page: 11A; Enumeration District: 0114; Image: 68.0; FHL microfilm: 2339997
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Hartford Ward 10, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 15B; Enumeration District: 127; Image: 537
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 262; Page: 11A; Enumeration District: 0114; Image: 68.0; FHL microfilm: 2339997
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
37 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Hartford Ward 10, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 15B; Enumeration District: 127; Image: 537
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
38 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019;
39 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2019;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person