Martha TROTT

Martha TROTT

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Martha TROTT [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 28. April 1896 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
Bestattung 1952 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Tod 27. Januar 1952 Canandaigua, Ontario, New York, USA nach diesem Ort suchen [31] [32]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1927 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1930 Marion, Wayne, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1935 Canandaigua, Ontario, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1. April 1940 Canandaigua, Ontario, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Heirat 11. Juli 1923 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42] [43] [44]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
11. Juli 1923
Rochester, Monroe, New York, USA
Patrick John Joseph DALY

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 03; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 204; Image: 96
3 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 06; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 0204; FHL microfilm: 1375006
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 8B; Enumeration District: 0127; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Canandaigua, Ontario, New York; Roll: T627_2706; Page: 63B; Enumeration District: 35-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Marion, Wayne, New York; Roll: 1658; Page: 9A; Enumeration District: 0025; Image: 403.0; FHL microfilm: 2341392
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
9 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
10 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
12 New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
13 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
14 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
15 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
16 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 03; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 204; Image: 96
18 International Genealogical Index(R), downloaded 5 Jul 2005
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
19 International Genealogical Index(R), downloaded 25 Sep 2005
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
20 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T623 1077; Page: 8A; Enumeration District: 127
21 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 06; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 0204; FHL microfilm: 1375006
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 8B; Enumeration District: 0127; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Canandaigua, Ontario, New York; Roll: T627_2706; Page: 63B; Enumeration District: 35-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Marion, Wayne, New York; Roll: 1658; Page: 9A; Enumeration District: 0025; Image: 403.0; FHL microfilm: 2341392
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
27 New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
28 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
29 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
30 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
32 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
33 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 03; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
35 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
36 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 06; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Marion, Wayne, New York; Roll: 1658; Page: 9A; Enumeration District: 0025; Image: 403.0; FHL microfilm: 2341392
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
38 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Canandaigua, Ontario, New York; Roll: T627_2706; Page: 63B; Enumeration District: 35-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Canandaigua, Ontario, New York; Roll: T627_2706; Page: 63B; Enumeration District: 35-6
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 8B; Enumeration District: 0127; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
41 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 0204; FHL microfilm: 1375006
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
42 New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
43 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
44 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person