Harriet SCHICKER

Harriet SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Harriet SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Name Hattie SCHICKER

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 9. April 1897 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Tod Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1935 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1940 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen [29]
Heirat 28. Juni 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30] [31]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. Juni 1917
Rochester, Monroe, New York, USA
Charles A SCHROEDER

Quellenangaben

1 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 4A; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 8B; Enumeration District: 186; Image: 117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
6 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 5A; Enumeration District: 0210; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
8 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 11A; Enumeration District: 28-39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
9 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
11 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 4A; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
12 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 8B; Enumeration District: 186; Image: 117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 1900 US Census, NY, Monroe Co, Rochester, Ward 17 p 191A, 153 Alphonse St
16 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 5A; Enumeration District: 0210; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
17 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
18 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 11A; Enumeration District: 28-39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
19 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
20 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 11A; Enumeration District: 28-39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02679; Page: 11A; Enumeration District: 28-39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 10B; Enumeration District: 0118; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
24 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 4A; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 5A; Enumeration District: 0210; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
28 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T625_1124; Page: 8B; Enumeration District: 186; Image: 117
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 Monroe Co NY Surrogate Court Record #1928-1143, Catherine Schicker
30 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
31 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person