Elizabeth HORNER
♀ Elizabeth HORNER
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 2. Februar 1864 | Pateley Bridge, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen | [6] [7] [8] [9] [10] |
Taufe | 8. März 1864 | Pateley Bridge, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen | |
Tod | 1957 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "after 1957") | Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen | |
Einwanderung | 1880 | from England to Grand Rapids, Michigan, United States nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1878 | Pocklington, East Riding, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1910 | Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [11] |
Wohnen | 1930 | Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [12] |
Wohnen | 1900 | Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [13] |
Wohnen | 1871 | Yeadon, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen | [14] |
Arrival | 16. August 1880 | New York nach diesem Ort suchen | [15] |
Departure | Liverpool, England and Queenstown, Ireland nach diesem Ort suchen | [16] |
Quellenangaben
1 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
2 | 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21B; Enumeration District: 58. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1001; Page: 27A; Enumeration District: 44; Image: 692.0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
8 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21B; Enumeration District: 58. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1001; Page: 27A; Enumeration District: 44; Image: 692.0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
10 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
11 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
12 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1001; Page: 27A; Enumeration District: 44; Image: 692.0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
13 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21B; Enumeration District: 58. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
14 | 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
15 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
16 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
Datenbank
Titel | Horner Kaftan family tree |
Beschreibung | Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer |
Hochgeladen | 2018-04-15 14:28:39.0 |
Einsender | Laura K. |
laamka@yahoo.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |