Martha Theresa BEIKIRCH

Martha Theresa BEIKIRCH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Martha Theresa BEIKIRCH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 15. April 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Bestattung Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Tod 1. Oktober 1969 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29] [30]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1. Juni 1925 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1930 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1933 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1935 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1. April 1940 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Heirat 5. November 1914 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42] [43] [44] [45]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
5. November 1914
Rochester, Monroe, New York, USA
George G. SCHICKER

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 18; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 8A; Enumeration District: 0224; Image: 357.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 8A; Enumeration District: 97; Image: 936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 03; Assembly District: 01; City: Irondequoit; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 13B; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 131-16-9105; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 16A; Enumeration District: 28-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 7A; Enumeration District: 0183; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
14 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
15 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
16 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; County: Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
17 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 18; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 8A; Enumeration District: 0224; Image: 357.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 8A; Enumeration District: 97; Image: 936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 03; Assembly District: 01; City: Irondequoit; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 13B; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 131-16-9105; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 16A; Enumeration District: 28-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 7A; Enumeration District: 0183; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
27 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; County: Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
28 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 131-16-9105; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; County: Monroe; Page: 07
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
32 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 05; City: Rochester Ward 18; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 03; Assembly District: 01; City: Irondequoit; : Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: 1447; Page: 8A; Enumeration District: 0224; Image: 357.0; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 7A; Enumeration District: 0183; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
37 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 16A; Enumeration District: 28-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Irondequoit, Monroe, New York; Roll: T627_2679; Page: 16A; Enumeration District: 28-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: 1076; Page: 13B; Enumeration District: 0115; FHL microfilm: 1241076
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
40 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 8A; Enumeration District: 97; Image: 936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
42 Most Holy Redeemer Baptisms (1867-1918), Roll 6, Item 12, Diocese of Rochester records at Nazareth College Library, 1887, #139
43 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
44 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
45 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person